PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04132575
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    • Outro comércio a retalho não em estabelecimentos, bancas ou mercados (47990) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
    • Aluguel e leasing de outras máquinas, equipamentos e bens tangíveis n.e.c. (77390) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LAW 2251 LIMITED29/12/200029/12/2000

    Quais são as últimas contas de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2016

    Quais são as últimas submissões para PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Término da nomeação de Mark Peter Evans como secretário em 24/05/2018

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Mark Peter Evans como diretor em 24/05/2018

    1 páginasTM01

    Aviso de mudança da administração para dissolução

    22 páginasAM23

    Relatório de progresso do administrador

    28 páginasAM10

    Declaração de proposta do administrador

    40 páginasAM03

    Aviso da aprovação presumida das propostas

    3 páginasAM06

    Declaração de negócios com formulário 2.14B

    19 páginas2.16B

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 4 Boundary Court Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UD para Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL em 30/03/2017

    2 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    Contas anuais preparadas até 31/03/2016

    29 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 09/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 15

    1 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 09/12/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/02/2016

    Estado do capital em 03/02/2016

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Contas para uma sociedade média preparadas até 31/03/2015

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/12/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/01/2015

    Estado do capital em 12/01/2015

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Término da nomeação de John Pinkney como diretor em 25/03/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Wayne Homes como diretor em 25/03/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Vernon Bradley como diretor em 25/03/2014

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade média preparadas até 31/03/2014

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/12/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/01/2014

    Estado do capital em 15/01/2014

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Contas para uma sociedade média preparadas até 31/03/2013

    17 páginasAA

    Contas para uma sociedade média preparadas até 31/03/2012

    20 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/12/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    legacy

    6 páginasMG01

    Quem são os diretores de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ECCLESHALL, Christopher James
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Diretor
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish100000660001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Secretário
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    British78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Secretário
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    EVERSECRETARY LIMITED
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    Secretário
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    60471940015
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretário
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretário nomeado
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    BRADLEY, Stephen Vernon
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish38805680002
    BRAMHALL, Darren
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    Diretor
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    United KingdomBritish139463440001
    BRAMHILL, Darren
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    Diretor
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    United KingdomBritish117298110001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Diretor
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Diretor
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    HOMES, David Wayne
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154849800001
    PINKNEY, John
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154856180001
    RATCLIFFE, Eric George
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish32530880003
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Diretor nomeado
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Diretor nomeado
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    09/12/2016A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge over sub-hire agreements
    Criado em 15/10/2012
    Entregue em 23/10/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The secured property, being- all right title interest and benefit in and to the sub-hire agreements see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 23/10/2012Registro de uma garantia (MG01)
    Debenture
    Criado em 01/05/2008
    Entregue em 07/05/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank PLC
    Transações
    • 07/05/2008Registro de uma garantia (395)
    Chattels mortgage
    Criado em 19/11/2004
    Entregue em 20/11/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no:ccns-102 s/no 105/3/D531. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no: ccns-103 s/no 105/3/D532.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transações
    • 20/11/2004Registro de uma garantia (395)
    • 19/02/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Chattels mortgage
    Criado em 19/02/2004
    Entregue em 20/02/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Jack leg office/mess cabin units - s/nos 3/8062, 3/8063, s/8060, 3/8244, s/8692, 3/8957, 3/9056, 3/9070, 3/9101, 3/8982, N576, N594, N662, 3/8942. pallet racking s/no:B0051. Tiger hoist s/no's 777432-777437.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 20/02/2004Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 18/12/2003
    Entregue em 19/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule such as welding stands and frames with dustribution boards and accessories. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 19/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 08/10/2003
    Entregue em 09/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    50 mastertig 350 mls welding machines,ser/nos 1108570,1108571,1108572 with all chattels plant machinery and things thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transações
    • 09/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 24/09/2003
    Entregue em 25/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being isuzu tf mega 2.5 tdi D. cab 4X4, chassis no. JAATFS54H27103683 pallet racking, s/no. D0336.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 25/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 18/06/2003
    Entregue em 20/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery 50 x mastertig 3500MLS welding machines serial numbers: 1096417, 1096418, 1097840 or any part thereof for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 20/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 05/06/2003
    Entregue em 06/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof:- 53 mastertig 3500MLS welding machines s/nos, 1073780, 1079468, 992661, 1065190, 1065191, for further details of chattels charged with serial numbers please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 06/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 28/05/2003
    Entregue em 29/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 29/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 14/03/2003
    Entregue em 15/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto and the copy invoices attached hereto or any part thereof, schedule: vauxhall omega cdx V6, chassis no; WOLOVBM6911098696.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 15/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 11/02/2003
    Entregue em 12/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    William hackett chains limited invoice numbers: op/0017699, OP0018057, OP0018460, OP0018520, OP0018020, hessle fork trucks limited invoice number 111756. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 12/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 05/02/2003
    Entregue em 06/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the copy invoices attached to the form 395 or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 06/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 03/09/2002
    Entregue em 03/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Vauxhall frontera 3.2I vg estate,reg/no NY02 uaw with all plant machinery and equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 03/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 28/03/2002
    Entregue em 28/03/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    2001 robin AR4001 digi multimeter - 5904. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 28/03/2002Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge (all assets)
    Criado em 14/08/2001
    Entregue em 16/08/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Breve descrição
    (I) all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto and (ii) all amounts of indebtedness due on any account whatsoever, all goodwill and uncalled capital, all patents and patent applications. The floating charge over the remainder of the underatking and all propery rights and assets whatsoever and wheresoever, both present and future including the company's stock in trade and its uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transações
    • 16/08/2001Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/06/2001
    Entregue em 12/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 12/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    06/03/2017Início da administração
    09/03/2018Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0