CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04140242
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    • Educação pré-escolar (85100) / Educação

    Onde fica CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Endereço do escritório registrado
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GAYNES PARK NURSERY LIMITED12/01/200112/01/2001

    Quais são as últimas contas de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Mary Ann Tocio como diretor em 01/06/2015

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/01/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/01/2015

    Estado do capital em 22/01/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    10 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/01/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/02/2014

    Estado do capital em 06/02/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/01/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Nomeação de Stephen Kramer como secretário

    1 páginasAP03

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    11 páginasAA

    Nomeação de Stephen Dreier como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de David Lissy como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mary Ann Tocio como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Elizabeth Boland como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mary Tocio como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Lissy como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Dreier como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Elizabeth Boland como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Kramer como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Stephen Kramer como secretário

    3 páginasAP03

    Diversos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Nomeação de Elizabeth Boland como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de David Lissy como diretor

    3 páginasAP01

    Quem são os diretores de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secretário
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    171973360001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    BROSNAN, Paul
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Secretário
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Irish102089360001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Secretário
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    British2462470003
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretário
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secretário
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secretário
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    British169896160001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretário
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Diretor
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Diretor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Diretor
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Diretor
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish2462470003
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    HEMSLEY, Maarten Duncan
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    Diretor
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    United StatesBritish69602210003
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Diretor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican218331690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Diretor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    PACE, Martin
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    Diretor
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    EnglandBritish74305820001
    TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    Diretor
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    United KingdomAustrian11820520001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Diretor
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 21/12/2004
    Entregue em 06/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,the Security Trustee
    Transações
    • 06/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 04/12/2002
    Entregue em 06/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Freehold property 105 gaynes park road upminster essex t/n EX21073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/12/2002
    Entregue em 06/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/12/2001
    Entregue em 08/01/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property k/a 105 gaynes park road upminster RM14 2HX and all rights relating to the schedule property together with the contracts the book debts the intellectual property the plant and machinery the shares and derivative assets the goodwill and uncalled capital. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transações
    • 08/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 30/04/2001
    Entregue em 03/05/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    105 gaynes park road upminster RM14 2HX.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transações
    • 03/05/2001Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0