AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED

AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAH MEDICAL PROPERTIES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04188281
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Brew House
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    AH MEDICAL PROPERTIES PLC11/01/200711/01/2007
    ASHLEY HOUSE PROPERTIES LIMITED 19/04/200419/04/2004
    SOHO HEALTH PLAZA LTD01/08/200101/08/2001
    FIRVALE LIMITED27/03/200127/03/2001

    Quais são as últimas contas de AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2020

    Quais são as últimas submissões para AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/03/2020

    10 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/04/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/03/2019

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/04/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2018

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/04/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado The Brew House Greenalls Avenue Warrington England WA4 6HL

    1 páginasAD04

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Capita Registrars Bourne House 34 Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4TU para The Brew House Greenalls Avenue Warrington WA4 6HL

    1 páginasAD02

    Cessação de Assura Group Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    1 páginasPSC07

    Notificação de Assura Plc como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC02

    Término da nomeação de Andrew Simon Darke como diretor em 08/01/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Orla Ball como diretor em 08/01/2018

    2 páginasAP01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/03/2017

    15 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/04/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2016

    17 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew Simon Darke em 20/04/2016

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 12/04/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/04/2016

    Estado do capital em 13/04/2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew Simon Darke em 15/12/2015

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2015

    12 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew Simon Darke em 27/08/2015

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 12/04/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/04/2015

    Estado do capital em 16/04/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Assura Limited em 16/12/2014

    1 páginasCH02

    Quem são os diretores de AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BALL, Orla Marie
    WA4 6HL Greenalls Avenue
    The Brew House
    Warrington
    United Kingdom
    Diretor
    WA4 6HL Greenalls Avenue
    The Brew House
    Warrington
    United Kingdom
    EnglandBritish199861060001
    ASSURA CS LIMITED
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Diretor
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro07184790
    149895250002
    BAILEY, David Charles
    Cemlyn
    Ton Road Llangybi
    NP15 1PA Usk
    Monmouthshire
    Secretário
    Cemlyn
    Ton Road Llangybi
    NP15 1PA Usk
    Monmouthshire
    British95338890001
    MINION, Kate Elizabeth
    Willow Place
    Falcons Croft
    HP10 0NP Wooburn Moor
    Buckinghamshire
    Secretário
    Willow Place
    Falcons Croft
    HP10 0NP Wooburn Moor
    Buckinghamshire
    British69215500004
    RONALDSON, Stephen Frank
    221 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    Secretário
    221 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    British1772340003
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Secretário nomeado
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    BROWN, John Kenneth
    9 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5DY Glasgow
    Diretor
    9 Lochbroom Drive
    Newton Mearns
    G77 5DY Glasgow
    ScotlandBritish462890004
    BURTON, Anthony David
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    UkBritish3513950001
    DARKE, Andrew Simon
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish65166580004
    GUNN, John Humphrey
    Edwardes Square
    W8 6HE London
    23
    Diretor
    Edwardes Square
    W8 6HE London
    23
    EnglandBritish705110002
    GUNN, John Humphrey
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Diretor
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    EnglandBritish705110002
    HOLMES, Jonathan
    61 The Spinney
    HP9 1SA Beaconsfield
    Bucks
    Diretor
    61 The Spinney
    HP9 1SA Beaconsfield
    Bucks
    British107261280001
    MINION, Stephen Gregory
    Linkswood Cottage 2 Linkswood Road
    Burnham
    SL1 8AT Slough
    Berkshire
    Diretor
    Linkswood Cottage 2 Linkswood Road
    Burnham
    SL1 8AT Slough
    Berkshire
    EnglandBritish40537330005
    RAWLINGS, Nigel Keith
    Hollin Lane
    SK9 4JH Styal
    18
    Cheshire
    Diretor
    Hollin Lane
    SK9 4JH Styal
    18
    Cheshire
    EnglandBritish7127460001
    WALKER, Bruce Layland
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Diretor
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    United KingdomBritish82714410001
    WEAVER, Christopher Giles Herron
    Greywalls Hotel
    EH31 2EG Gullane
    Lothian
    Diretor
    Greywalls Hotel
    EH31 2EG Gullane
    Lothian
    ScotlandBritish1251050001
    WILKINSON, Peter John
    5 Lauds Close
    RG9 1UX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    5 Lauds Close
    RG9 1UX Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish34867100001
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Diretor nomeado
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001

    Quem são as pessoas com controle significativo de AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Assura Group Limited
    La Grande Rue
    GY4 6RT St Martin's
    Old Bank Chambers
    Guernsey
    06/04/2016
    La Grande Rue
    GY4 6RT St Martin's
    Old Bank Chambers
    Guernsey
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroGuernsey
    Autoridade legalGuernsey
    Local de registroGuernsey
    Número de registro41230
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    06/04/2016
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brew House
    England
    England
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company (Listed)
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro09349441
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    AH MEDICAL PROPERTIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 05/07/2010
    Entregue em 08/07/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Graham Tobbell (As Security Trustee)
    Transações
    • 08/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 28/03/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of assigment
    Criado em 12/05/2006
    Entregue em 25/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease in respect of medical cente kepple lane garstang lancashire,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 25/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed
    Criado em 27/01/2006
    Entregue em 14/02/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited (Trustee)
    Transações
    • 14/02/2006Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of assignment
    Criado em 09/12/2005
    Entregue em 14/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 14/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of assignment
    Criado em 25/10/2005
    Entregue em 28/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease/S. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 28/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of assignment
    Criado em 22/09/2005
    Entregue em 23/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the lease in respect of land being at brook square trafalgar street west scarborough.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 23/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed
    Criado em 11/03/2005
    Entregue em 26/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H property at kepple lane garstang preston including all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery, all moneys deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 26/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 14 october 2004)
    Criado em 25/01/2005
    Entregue em 02/02/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land being part land on the west side of the road leading from brill to thame, brill, including all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery. All monies deposited with the trustee;.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 02/02/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed
    Criado em 01/12/2004
    Entregue em 17/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land on the south side of longmead avenue great baddow essex together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. All moneys from time to time deposited with the trustee.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 17/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 14 october 2004)
    Criado em 29/10/2004
    Entregue em 13/11/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land at brook square scarborough including all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery. All monies deposited with the trustee.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 13/11/2004Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of assignment and charge
    Criado em 14/10/2004
    Entregue em 27/10/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title benefit and interest in the development agreement dated 3 september 2004 and in the assignment dated 14 october 2004.
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 27/10/2004Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Criado em 14/10/2004
    Entregue em 27/10/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from ashley house PLC to the general practice finance corporation limited ('trustee') under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land adjoining coombe girls school clarence avenue new malden kingston upon thames together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Pessoas com direito
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transações
    • 27/10/2004Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0