ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 04204273 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
TOREX HEALTH (HOLDINGS) LIMITED | 16/05/2001 | 16/05/2001 |
SPEED 8730 LIMITED | 24/04/2001 | 24/04/2001 |
Quais são as últimas contas de ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2012 |
Qual é o status da última declaração anual para ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Declaração anual |
|
---|
Quais são as últimas submissões para ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 24/04/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/03/2013 para 30/09/2013 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Nomeação de Michael Charles Woodfine como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Nomeação de Stuart Malcolm Adams como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Gray como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Thomson como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 24/04/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Nomeação de David William Hart Gray como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Gareth Wilson como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Adrian Stevens como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 24/04/2012 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/06/2011 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Exercício contabilístico atual encurtado de 30/06/2012 para 31/03/2012 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew James Edward Thomson em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Adrian Charles Stevens em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Gareth Antony Wilson em 12/09/2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Andrea Fiumicelli em 12/09/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* em 18/08/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* em 05/08/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Quem são os diretores de ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOODFINE, Michael Charles | Secretário | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 183106850001 | ||||||
ADAMS, Stuart Malcolm | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | Australian | Accountant | 183104980001 | ||||
FIUMICELLI, Andrea | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
EDELMAN, Howard Todd | Secretário | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
GRAY, David William Hart | Secretário | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177358080001 | ||||||
HILL, Teifion Mark | Secretário | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
HORN, Nigel David | Secretário | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
WILSON, Gareth Antony | Secretário | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162049220001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
COHEN, Gary Michael | Diretor | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
GARRINGTON, Stephen John | Diretor | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | Director | 45513680001 | |||||
GRAHAM, Stephen Paul | Diretor | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Director | 97528710001 | ||||
HENRY, William Patrick | Diretor | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Diretor | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Diretor | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Director | 101025710001 | |||||
MACKAY, James Gordon | Diretor | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
MACKAY, James Gordon | Diretor | Pogles Wood Widmoor HP10 0JG Wooburn Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | Accountant | 178097680001 | ||||
PEARMAN, Mark Chalice | Diretor | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
RICHARDS, Paul | Diretor | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
SPRIGG, Mark | Diretor | Apartment 5 Oliver's Lock Payton Street CV37 6PS Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Commercial Director | 93099470001 | |||||
STEVENS, Adrian Charles | Diretor | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Diretor | Wellesley Road GU11 1 PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
WHELAN, John | Diretor | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Diretor | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Director | 69575560002 | ||||
WOODBRIDGE, Mark Gavin | Diretor | The Bungalow Marton CV23 9RS Rugby Warwickshire | British | Finance Director | 74738270002 | |||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
ISOFT HEALTH (HOLDINGS) LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Criado em 30/12/2009 Entregue em 14/01/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All the security under the deed see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Security agreement | Criado em 30/12/2009 Entregue em 13/01/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A security agreement | Criado em 11/12/2007 Entregue em 27/12/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of accession | Criado em 27/11/2007 Entregue em 13/12/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Criado em 25/06/2004 Entregue em 01/07/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts. Floating charge all undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A legal charge containing fixed and floating charges | Criado em 21/07/2003 Entregue em 06/08/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0