STADCO HOLDINGS LTD.
Visão geral
| Nome da empresa | STADCO HOLDINGS LTD. |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04215953 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de STADCO HOLDINGS LTD.?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica STADCO HOLDINGS LTD.?
| Endereço do escritório registrado | International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| OFFSHELF 282 LTD | 14/05/2001 | 14/05/2001 |
Quais são as últimas contas de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para STADCO HOLDINGS LTD.?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 15/10/2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Mark John Smith em 18/04/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Christopher Paul Fisher em 18/04/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW para International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE em 07/10/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark John Smith como secretário em 05/09/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Hayhurst como secretário em 05/09/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 08/05/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark John Smith como diretor em 30/11/2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Christopher Paul Fisher como diretor em 30/11/2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Gregory Ian Macleod como diretor em 30/10/2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Gordon Hussey como diretor em 30/11/2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL para Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW em 29/12/2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 042159530006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Quem são os diretores de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mark John | Secretário | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | 213570940001 | |||||||
| FISHER, Christopher Paul | Diretor | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 183747270001 | |||||
| SMITH, Mark John | Diretor | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 124719430001 | |||||
| HAYHURST, Michael | Secretário | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | British | 15201970002 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Secretário | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| OTHERS INTERESTS LTD | Secretário | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 103784950001 | |||||||
| COOK, Jonathan Charles | Diretor | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 72559760001 | ||||||
| HUSSEY, David Gordon | Diretor | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | England | British | 131639570002 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Diretor | Callingwood Lane Tatenhill DE13 9SH Burton-On-Trent Callingwood Hall Staffordshire United Kingdom | British | 131639570001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Diretor | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Diretor | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Diretor | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Diretor | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Diretor | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | England | British | 11643310001 | |||||
| ROACHE, David John | Diretor | Fallowfield Badgers Lane CV35 0BY Lower Tysoe Warwickshire | United Kingdom | British | 40953790002 | |||||
| STERNE, Dermot Desmond | Diretor | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | Uk | British | 96569780001 | |||||
| SWORD, John David | Diretor | Chivel OX7 5TR Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 1600540001 | |||||
| WILLIS, David John | Diretor | Damson Cottage Highfields SY4 5UN Wem Shropshire | British | 51085590002 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Diretor | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| OFFSHELF LTD | Diretor | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 42228870001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertec Engineering Limited | 06/04/2016 | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
STADCO HOLDINGS LTD. possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 29/08/2013 Entregue em 06/09/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 29/08/2013 Entregue em 04/09/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 23/11/2005 Entregue em 01/12/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge | Criado em 28/02/2003 Entregue em 06/03/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 28/02/2003 Entregue em 06/03/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Pledge of shares | Criado em 23/07/2002 Entregue em 07/08/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição 926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Supplemental deed to the target group debenture | Criado em 23/07/2002 Entregue em 07/08/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0