STADCO HOLDINGS LTD.

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSTADCO HOLDINGS LTD.
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04215953
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de STADCO HOLDINGS LTD.?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica STADCO HOLDINGS LTD.?

    Endereço do escritório registrado
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    OFFSHELF 282 LTD14/05/200114/05/2001

    Quais são as últimas contas de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para STADCO HOLDINGS LTD.?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 15/10/2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Mark John Smith em 18/04/2019

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Christopher Paul Fisher em 18/04/2019

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    16 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 08/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW para International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE em 07/10/2016

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Mark John Smith como secretário em 05/09/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Michael Hayhurst como secretário em 05/09/2016

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 08/05/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/05/2016

    Estado do capital em 09/05/2016

    • Capital: GBP 19,155,439
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    20 páginasAA

    Nomeação de Mr Mark John Smith como diretor em 30/11/2015

    3 páginasAP01

    Nomeação de Mr Christopher Paul Fisher como diretor em 30/11/2015

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Gregory Ian Macleod como diretor em 30/10/2015

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de David Gordon Hussey como diretor em 30/11/2015

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL para Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW em 29/12/2015

    2 páginasAD01

    Satisfação total da garantia 042159530006

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Secretário
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Diretor
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Diretor
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Secretário
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Secretário
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretário
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Diretor
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Diretor
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Diretor
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Diretor
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Diretor
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Diretor
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Diretor
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Diretor
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    Diretor
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    Quem são as pessoas com controle significativo de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    06/04/2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro555532
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    STADCO HOLDINGS LTD. possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 29/08/2013
    Entregue em 06/09/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transações
    • 06/09/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 16/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 29/08/2013
    Entregue em 04/09/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 04/09/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 16/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 23/11/2005
    Entregue em 01/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transações
    • 01/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 16/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of charge
    Criado em 28/02/2003
    Entregue em 06/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/02/2003
    Entregue em 06/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Pledge of shares
    Criado em 23/07/2002
    Entregue em 07/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    Transações
    • 07/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 11/12/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    Criado em 23/07/2002
    Entregue em 07/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    Transações
    • 07/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 11/12/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0