INGLEBY SUB LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | INGLEBY SUB LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04240184 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de INGLEBY SUB LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica INGLEBY SUB LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Highfield Court Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ROAD ANGEL GROUP LIMITED | 28/09/2006 | 28/09/2006 |
| BLACK SPOT INTERACTIVE LIMITED | 13/09/2001 | 13/09/2001 |
| EGGSHELL (467) LIMITED | 25/06/2001 | 25/06/2001 |
Quais são as últimas contas de INGLEBY SUB LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2019 |
Quais são as últimas submissões para INGLEBY SUB LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2019 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Pritchard Williams como diretor em 28/06/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Stefan Leon Borson como diretor em 07/11/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Edward Ian Charles Walker como secretário em 07/11/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS England para Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh SO53 3TY em 13/02/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2017 com atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notificação de Ingleby (1653) Limited como pessoa com controlo significativo em 04/06/2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Clark House Silverstone Technology Park Silverstone Circuit Silverstone Northamptonshire NN12 8GX para 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS em 09/01/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
A ação de exclusão obrigatória foi suspensa | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 25/06/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Edward Ian Charles Walker como secretário em 31/05/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Quem são os diretores de INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORSON, Stefan Leon | Diretor | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 117811010002 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Secretário | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | British | 75329780001 | ||||||
| ESSACK, Ismail | Secretário | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 180702250001 | |||||||
| THICKBROOM, Mark Gordon | Secretário | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 150676770001 | |||||||
| WALKER, Edward Ian Charles | Secretário | Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham 1 Hampshire England | 208796400001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BOWDEN ROOKE, Stuart Lee | Diretor | 14 Mansell Close NN12 7AY Towcester Northamptonshire | British | 142390750001 | ||||||
| CHAPMAN, Stuart Malcolm | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6LB London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 98452660001 | |||||
| CLARK, David William | Diretor | Gilbury Farm Gilbury Lane SO45 1AG Exbury Hampshire | England | British | 91168600003 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Diretor | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | United Kingdom | British | 75329780001 | |||||
| ESSACK, Ismail | Diretor | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 67640350001 | |||||
| KEANE, Adrian Spencer | Diretor | Dale Acre Barn Main Street DE74 2RH Lockington Derby | United Kingdom | British | 62552110002 | |||||
| MACKIE, Graham Robert | Diretor | 4 The Paddocks MK43 8LT Bedford Bedfordshire | England | British | 123305710001 | |||||
| MEECHAN, Richard John | Diretor | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 167193130001 | |||||
| READ, Jonathan Hugh Tobias | Diretor | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 154632910001 | |||||
| SADIQ, Hassan Saadi | Diretor | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 118639040001 | |||||
| SALMON, Steven Kenneth | Diretor | Valley Farm Hanbury Road B60 4HJ Hanbury Worcestershire | England | British | 142390760001 | |||||
| THICKBROOM, Mark | Diretor | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Clark House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 116064810002 | |||||
| WILLIAMS, Mark Pritchard | Diretor | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 198092340001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingleby (1653) Limited | 04/06/2016 | Home Ground Barn Pury Hill Business Park NN12 7LS Towcester 2nd Floor England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
INGLEBY SUB LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 23/06/2015 Entregue em 23/06/2015 | Pendente | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 26/03/2012 Entregue em 31/03/2012 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 september 2005 and | Criado em 10/07/2010 Entregue em 21/07/2010 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deposit deed | Criado em 23/09/2005 Entregue em 30/09/2005 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição £85,187.50 and any interest thereon for the time being standing to the credit of the seperate designated interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage of a life policy | Criado em 19/09/2005 Entregue em 01/10/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All money including bonuses that have accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and rights given in connection with the policy and all rights and interests in the policy. The policy means the life assurance policy on the life of mr david clark dated 26TH january 2004 with the financial services limited policy number 010644900-2 in the sum of £500,000 for a period of 5 years. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 19/09/2005 Entregue em 01/10/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Criado em 19/09/2005 Entregue em 01/10/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Intellectual property rights charge | Criado em 19/09/2005 Entregue em 01/10/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All rights in rights and patents know-how registered trade marks registered designs utility models applications for the rights to apply for any of the foregoing unregistered design rights unregistered trade marks the rights to prevent passing off for unfair competition and copyright database rights topography rights and any other rights. The goodwill relating to any of the intellectual property. Every item of physical material of any description in respect of which the intellectual property rights may subsist. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Rent deposit deed | Criado em 31/10/2002 Entregue em 05/11/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £3,675.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição A designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0