INGLEBY SUB LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINGLEBY SUB LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04240184
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INGLEBY SUB LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica INGLEBY SUB LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Highfield Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INGLEBY SUB LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROAD ANGEL GROUP LIMITED28/09/200628/09/2006
    BLACK SPOT INTERACTIVE LIMITED13/09/200113/09/2001
    EGGSHELL (467) LIMITED25/06/200125/06/2001

    Quais são as últimas contas de INGLEBY SUB LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2019

    Quais são as últimas submissões para INGLEBY SUB LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2019

    21 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    21 páginasAA

    Término da nomeação de Mark Pritchard Williams como diretor em 28/06/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Stefan Leon Borson como diretor em 07/11/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Edward Ian Charles Walker como secretário em 07/11/2018

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name28/03/2018

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Endereço do domicílio registado alterado de 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS England para Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh SO53 3TY em 13/02/2018

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    26 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/06/2017 com atualizações

    3 páginasCS01

    Notificação de Ingleby (1653) Limited como pessoa com controlo significativo em 04/06/2016

    2 páginasPSC02

    Endereço do domicílio registado alterado de Clark House Silverstone Technology Park Silverstone Circuit Silverstone Northamptonshire NN12 8GX para 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS em 09/01/2017

    1 páginasAD01

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    25 páginasAA

    A ação de exclusão obrigatória foi suspensa

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Declaração anual preparada até 25/06/2016 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/07/2016

    Estado do capital em 01/07/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomeação de Mr Edward Ian Charles Walker como secretário em 31/05/2016

    2 páginasAP03

    Quem são os diretores de INGLEBY SUB LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BORSON, Stefan Leon
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    Diretor
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    EnglandBritish117811010002
    EAGLE, Anthony Joseph
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    Secretário
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    British75329780001
    ESSACK, Ismail
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Secretário
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    180702250001
    THICKBROOM, Mark Gordon
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Secretário
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    150676770001
    WALKER, Edward Ian Charles
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    Secretário
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    208796400001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BOWDEN ROOKE, Stuart Lee
    14 Mansell Close
    NN12 7AY Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    14 Mansell Close
    NN12 7AY Towcester
    Northamptonshire
    British142390750001
    CHAPMAN, Stuart Malcolm
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    14
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish98452660001
    CLARK, David William
    Gilbury Farm
    Gilbury Lane
    SO45 1AG Exbury
    Hampshire
    Diretor
    Gilbury Farm
    Gilbury Lane
    SO45 1AG Exbury
    Hampshire
    EnglandBritish91168600003
    EAGLE, Anthony Joseph
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    Diretor
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish75329780001
    ESSACK, Ismail
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Diretor
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    EnglandBritish67640350001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Diretor
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    United KingdomBritish62552110002
    MACKIE, Graham Robert
    4 The Paddocks
    MK43 8LT Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    4 The Paddocks
    MK43 8LT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish123305710001
    MEECHAN, Richard John
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Diretor
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    EnglandBritish167193130001
    READ, Jonathan Hugh Tobias
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Diretor
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish154632910001
    SADIQ, Hassan Saadi
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Diretor
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish118639040001
    SALMON, Steven Kenneth
    Valley Farm
    Hanbury Road
    B60 4HJ Hanbury
    Worcestershire
    Diretor
    Valley Farm
    Hanbury Road
    B60 4HJ Hanbury
    Worcestershire
    EnglandBritish142390760001
    THICKBROOM, Mark
    Technology Park, Silverstone Circuit
    Silverstone
    NN12 8GX Towcester
    Clark House
    Northamptonshire
    England
    Diretor
    Technology Park, Silverstone Circuit
    Silverstone
    NN12 8GX Towcester
    Clark House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish116064810002
    WILLIAMS, Mark Pritchard
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    Diretor
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    EnglandBritish198092340001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Quem são as pessoas com controle significativo de INGLEBY SUB LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Home Ground Barn
    Pury Hill Business Park
    NN12 7LS Towcester
    2nd Floor
    England
    04/06/2016
    Home Ground Barn
    Pury Hill Business Park
    NN12 7LS Towcester
    2nd Floor
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalEngland And Wales
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05436711
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    INGLEBY SUB LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 23/06/2015
    Entregue em 23/06/2015
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 23/06/2015Registro de uma garantia (MR01)
    Debenture
    Criado em 26/03/2012
    Entregue em 31/03/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Dfj Esprit LLP as Security Trustee for Each Group Member
    Transações
    • 31/03/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 september 2005 and
    Criado em 10/07/2010
    Entregue em 21/07/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 21/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deposit deed
    Criado em 23/09/2005
    Entregue em 30/09/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    £85,187.50 and any interest thereon for the time being standing to the credit of the seperate designated interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Silverstone Estates Limited
    Transações
    • 30/09/2005Registro de uma garantia (395)
    Mortgage of a life policy
    Criado em 19/09/2005
    Entregue em 01/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All money including bonuses that have accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and rights given in connection with the policy and all rights and interests in the policy. The policy means the life assurance policy on the life of mr david clark dated 26TH january 2004 with the financial services limited policy number 010644900-2 in the sum of £500,000 for a period of 5 years.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 19/09/2005
    Entregue em 01/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 19/09/2005
    Entregue em 01/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Intellectual property rights charge
    Criado em 19/09/2005
    Entregue em 01/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All rights in rights and patents know-how registered trade marks registered designs utility models applications for the rights to apply for any of the foregoing unregistered design rights unregistered trade marks the rights to prevent passing off for unfair competition and copyright database rights topography rights and any other rights. The goodwill relating to any of the intellectual property. Every item of physical material of any description in respect of which the intellectual property rights may subsist. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Criado em 31/10/2002
    Entregue em 05/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £3,675.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    A designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society.
    Pessoas com direito
    • David George King and Carolyn Margaret King
    Transações
    • 05/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/01/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0