THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04258762
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    • (6523) /

    Onde fica THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    THINC DESTINI TRAIL COLLECTIONS LIMITED18/07/200618/07/2006
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED29/04/200529/04/2005
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP PLC27/06/200227/06/2002
    GREENOAK MARKETING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY30/08/200130/08/2001
    INDIGOHONEY PUBLIC LIMITED COMPANY25/07/200125/07/2001

    Quais são as últimas contas de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado do capital em 29/12/2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account and other reserve be reduced to zero 22/12/2011
    RES13

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Resoluções

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Término da nomeação de Alasdair Mackay como diretor

    2 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 23/04/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Jeremy Peter Small em 23/04/2010

    1 páginasCH03

    Nomeação de Alasdair Mackay como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de um diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2008

    14 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288c

    Contas anuais preparadas até 31/12/2007

    16 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secretário
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Diretor
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Secretário
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    O'CONOR, Patrick Francis
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    Secretário
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    British50372870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secretário
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    SMITH, Nicholas
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    Secretário
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishSolicitor83415330001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretário
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRISTOL, Teresa Louise
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    Diretor
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    BritishManager83991510001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Diretor
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    EVERILL, Jonathan Robert Edwin
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    Diretor
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    BritishIfa34156430003
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Diretor
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    BritishFinancial Adviser105488120003
    GALVIN WRIGHT, Jonathon William
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    Diretor
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    BritishMarketing Director79499790001
    GRIFFITHS, Mark Roderick Winton
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    Diretor
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    BritishSolicitor61034080001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Diretor
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishCompany Director98560430001
    LUMSDEN COOK, Anthony James
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Diretor
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishLloyds Underwriter78707170001
    MACKAY, Alasdair Iain
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Diretor
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishNone146368090001
    PARSONS, Barry Gilbert
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector91796850001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Diretor
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer130449650001
    SCOTT, Graham Leslie
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishIndependent Financial Adviser78187980001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Diretor nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 25/11/2005
    Entregue em 10/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 24/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/11/2005
    Entregue em 08/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Prudential UK Services Limited
    Transações
    • 08/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of life policy
    Criado em 04/06/2003
    Entregue em 21/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Scottish equitable policy no: L0194075832 dl (barry gilbert parsons). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of life policy
    Criado em 04/06/2003
    Entregue em 21/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Scottish equitable policy no: L0192175832 dt (david john collett). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/04/2003
    Entregue em 09/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0