SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED

SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04299748
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4th Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    G.P.E. (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED07/11/200107/11/2001
    SHELFCO (NO.2582) LIMITED05/10/200105/10/2001

    Quais são as últimas contas de SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    2 páginasAA

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Resolve to wind up company voluntarily and company secretary authorised to deal all matters thereto 22/06/2018
    RES13

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephane Abraham Joseph Nahum em 15/03/2017

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 05/10/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    2 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 05/10/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    2 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/10/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/10/2015

    Estado do capital em 06/10/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    2 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/10/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/10/2014

    Estado do capital em 06/10/2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    2 páginasAA

    Nomeação de Mr Patrick Colin O'driscoll como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 05/10/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/10/2013

    Estado do capital em 07/10/2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    2 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/10/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephane Abraham Joseph Nahum em 15/03/2011

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 05/10/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    5 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Malcolm Robin Turner em 27/06/2011

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Ross Mcdiven como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Alan Peach como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LANGRIDGE, Megan Joy
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    157794380001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    Diretor
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    EnglandFrenchPrivate Equity99292580035
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    England
    England
    Diretor
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    England
    England
    EnglandIrishAccountant75571770002
    TURNER, Malcolm Robin
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    Diretor
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    United KingdomBritishCompany Director60293070008
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Secretário
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor85605320001
    MARTIN, Desna Lee
    72 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Secretário
    72 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    British62162550003
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Secretário
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Secretário
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    BARROTT, Ronald Stephen
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    Diretor
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director9892700002
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishSolicitor122926460001
    CORCORAN, John Anthony
    7 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Diretor
    7 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    AustralianDirector79804100001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Diretor
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBank Executive68241910003
    GITTENS, Paul Alexander
    29 Woodland Way
    Woodford Wells
    IG8 0QQ Woodford
    Essex
    Diretor
    29 Woodland Way
    Woodford Wells
    IG8 0QQ Woodford
    Essex
    BritishChartered Surveyor14920090001
    KERR, Donald
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    Diretor
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    BritishBanker84247450001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    9 Greenbank Terrace
    EH10 6ER Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant94163020001
    MACLEOD, Alan Donald Ewen
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant107116780001
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Diretor
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    AustralianCompany Director108719480001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Diretor
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    BritishChartered Accountant73738070001
    MURPHY, Kevin Joseph John
    77b Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HS London
    Diretor
    77b Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HS London
    BritishSurveyor106832380002
    NATHAN, Timothy Paul
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    Diretor
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    United KingdomBritishFinance Director104162560001
    PEACH, Alan John
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    Diretor
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United KingdomBritishChartered Surveyor54797630003
    PESKIN, Richard Martin
    41 Circus Road
    St Johns Wood
    NW8 9JH London
    Diretor
    41 Circus Road
    St Johns Wood
    NW8 9JH London
    EnglandBritishCompany Director35018930001
    SHAW, Peter David Marley
    Worth Cottage
    9 Batchworth Heath
    WD3 1QB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    Worth Cottage
    9 Batchworth Heath
    WD3 1QB Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor74197750001
    WATTERS, Michael John
    51b Chesham Road
    Bryanston
    South Africa
    Diretor
    51b Chesham Road
    Bryanston
    South Africa
    South AfricanManaging Director79419220001
    WHITELEY, John Howard
    14 Fallows Green
    AL5 4HD Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    14 Fallows Green
    AL5 4HD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant48980090002
    MIKJON LIMITED
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    Diretor
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    72341560001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    England
    England
    06/04/2016
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor
    England
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05646757
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SAPPHIRE (HIGH WYCOMBE) (NO.2) NOMINEE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite debenture
    Criado em 06/03/2009
    Entregue em 10/03/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the wider obligors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale (Helaba), London Branch as Security Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transações
    • 10/03/2009Registro de uma garantia (395)
    Supplemental charge
    Criado em 25/06/2007
    Entregue em 28/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    L/H 14 octagon parade high wycombe.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 28/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 17/03/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/05/2006
    Entregue em 03/06/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The f/h land k/a 4 paul's row, high wycombe t/no BM138455, and the f/h property k/a 14 octagon parade, high wycombe t/no BM261391 and the l/h land k/a the octagon shopping centre, high wycombe t/no BM153513 for further property charged please refer to the form 395 including buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery and other structures. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Wycombe District Council
    Transações
    • 03/06/2006Registro de uma garantia (395)
    • 27/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental charge
    Criado em 22/05/2006
    Entregue em 24/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    L/H property k/a eden centre high wycombe,l/h land k/a two existing levels of car parking above the tesco store high wycombe including all buildings,fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 24/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 17/03/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/05/2006
    Entregue em 12/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 12/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 17/03/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/08/2005
    Entregue em 03/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/08/2005
    Entregue em 03/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land k/a 14 octagon parade high wycombe t/no BM261391. L/h land k/a the octagon shopping centre high wycombe t/no BM153513. F/h land k/a 4 st paul's row high wycombe t/no BM138455.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/11/2002
    Entregue em 05/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and sapphire (high wycombe) nominee to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Freehold property known as 14 octagon parade high wycombe title number BM261391. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Lenders)
    Transações
    • 05/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge between the company and the governor and company of the bank of scotland (as security trustee for the lenders (the "security trustee")
    Criado em 16/11/2001
    Entregue em 26/11/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of the company to the lenders (or any of them) whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise
    Breve descrição
    The l/h property k/a the octagon centre high wycombe t/n BM153513 and 4 pauls row high wycombe t/n BM138455 plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 26/11/2001Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 16/11/2001
    Entregue em 22/11/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to the lenders (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 22/11/2001Registro de uma garantia (395)
    • 08/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0