AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC

AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 04360804
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Endereço do escritório registrado
    Unit 2 Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Staffordshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ACCIDENT EXCHANGE GROUP PLC20/04/200420/04/2004
    XECUTIVERESEARCH GROUP PLC25/01/200225/01/2002

    Quais são as últimas contas de AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/02/2018

    Quais são as últimas submissões para AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Alpha 1 Canton Lane Hams Hall Birmingham B46 1GA para Unit 2 Liberty Park Burton Old Road Lichfield Staffordshire WS14 9HY em 21/04/2021

    1 páginasAD01

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 3

    2 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 043608040005

    1 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 043608040006

    1 páginasMR05

    Satisfação total da garantia 3

    2 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 043608040005

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 043608040006

    1 páginasMR04

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/08/2020

    10 páginasLIQ03

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/08/2019

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2019 com atualizações

    53 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Company business 04/10/2018
    RES13

    Contas anuais preparadas até 28/02/2018

    24 páginasAA

    Registo da garantia 043608040006, criada em 09/02/2018

    51 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2018 com atualizações

    13 páginasCS01

    Término da nomeação de Nicola Jane Catherine Roy como diretor em 14/12/2017

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Company business 08/11/2017
    RES13

    Contas consolidadas preparadas até 28/02/2017

    55 páginasAA

    Nomeação de Mr Richard Ewan Paul como diretor em 14/09/2017

    2 páginasAP01

    Registo da garantia 043608040005, criada em 14/09/2017

    51 páginasMR01

    Satisfação total da garantia 043608040004

    1 páginasMR04

    Término da nomeação de Stephen Anthony Evans como diretor em 23/05/2017

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SADIQ, Irfan
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    Secretário
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    195845750001
    PAUL, Richard Ewan
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    Diretor
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish49926100002
    WOODS, Lucy
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    Diretor
    Liberty Park
    Burton Old Road
    WS14 9HY Lichfield
    Unit 2
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish215423840001
    DAVIES, Dunstana Adeshola
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    Secretário
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    British55368820001
    JONES, Stephen Robert
    31 Cardinal Close
    Edgbaston
    B17 8EU Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    31 Cardinal Close
    Edgbaston
    B17 8EU Birmingham
    West Midlands
    British116907360002
    PICKERING, Nicola Jane Catherine
    41 Westwood Road
    B73 6UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretário
    41 Westwood Road
    B73 6UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British100664420003
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Secretário
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    Secretário
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    38636470004
    ANDREWS, Martin John
    Hazy Hill Farm
    248 Old Birmingham Road Marlbrook
    B60 1NU Bromsgrove
    Worcs
    Diretor
    Hazy Hill Farm
    248 Old Birmingham Road Marlbrook
    B60 1NU Bromsgrove
    Worcs
    EnglandBritish92737590002
    BULL, Michael Norman
    Shepherds Fold
    Finwood Road
    CV35 7DF Rowington
    Warwickshire
    Diretor
    Shepherds Fold
    Finwood Road
    CV35 7DF Rowington
    Warwickshire
    British12376800001
    COOKE, Andrew James
    Apartment 652
    37 Store Street
    WC1E 7QF London
    Diretor
    Apartment 652
    37 Store Street
    WC1E 7QF London
    British80364930001
    EVANS, Stephen Anthony, Dr
    The Dell
    33 Hartopp Road
    B74 2QR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    The Dell
    33 Hartopp Road
    B74 2QR Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandEnglish29008630002
    GALLOWAY, David Allistair
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    Diretor
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    EnglandBritish180591130001
    GUPTA, Daksh
    3 Hartshill Close
    Bloxham
    OX15 4QH Banbury
    Meadow Close
    Oxfordshire
    Diretor
    3 Hartshill Close
    Bloxham
    OX15 4QH Banbury
    Meadow Close
    Oxfordshire
    EnglandBritish134472480001
    HEYNES, David Gordon
    Newton House
    SN7 8PY Faringdon
    Oxfordshire
    Diretor
    Newton House
    SN7 8PY Faringdon
    Oxfordshire
    British2903320001
    LEES, David John
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    Diretor
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    United KingdomBritish65668260002
    ROY, Nicola Jane Catherine
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    Diretor
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    EnglandBritish173757200001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74298510001
    STANLEY, Graham Kemble
    7 Willow Lea
    Mollington
    CH1 6LW Chester
    Ranworth
    United Kingdom
    Diretor
    7 Willow Lea
    Mollington
    CH1 6LW Chester
    Ranworth
    United Kingdom
    EnglandBritish107533450002
    VAUGHAN FOWLER, James Nicholas
    Wheelstone House
    Buckland Marsh
    SN7 8RD Faringdon
    Oxon
    Diretor
    Wheelstone House
    Buckland Marsh
    SN7 8RD Faringdon
    Oxon
    British26962420001
    WHATLEY, David Andrew
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    Diretor
    Alpha 1
    Canton Lane
    B46 1GA Hams Hall
    Birmingham
    United KingdomBritish160537360001
    WILDES, Paul
    128 Abbey Lane
    S8 0BQ Sheffield
    Diretor
    128 Abbey Lane
    S8 0BQ Sheffield
    British110420660002
    WORSLEY, Francis Edward
    10 Whitehills Green
    RG8 0EB Goring On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    10 Whitehills Green
    RG8 0EB Goring On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish33894030002
    YOUNG-OF-GRAFFHAM, David Ivor, Lord
    28 York Terrace West
    NW1 4QA London
    Diretor
    28 York Terrace West
    NW1 4QA London
    United KingdomBritish79261740001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    23/01/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 09/02/2018
    Entregue em 14/02/2018
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Morgan Stanley Bank International Limited as Security Agent
    Transações
    • 14/02/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/02/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 08/02/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 14/09/2017
    Entregue em 19/09/2017
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Morgan Stanley Bank International Limited
    Transações
    • 19/09/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/02/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 08/02/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 25/01/2016
    Entregue em 09/02/2016
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Land at aplha 1, canton lane, hams hall. Birmingham t/no WK430026 units 25 and 26 optima park, ctayford. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Gqs Finance LTD
    Transações
    • 09/02/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 18/09/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 14/06/2007
    Entregue em 25/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor and a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Stanley Bank International Limited
    Transações
    • 25/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 08/02/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security trust deed
    Criado em 22/09/2006
    Entregue em 28/09/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 28/09/2006Registro de uma garantia (395)
    • 06/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 20/12/2004
    Entregue em 24/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 24/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 06/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    AUTOMOTIVE AND INSURANCE SOLUTIONS GROUP PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/08/2019Início da liquidação
    10/11/2021Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profissional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0