365 IT SUBCO NO.1 LIMITED

365 IT SUBCO NO.1 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresa365 IT SUBCO NO.1 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04366702
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    5I LIMITED05/02/200205/02/2002

    Quais são as últimas contas de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2009

    Quais são as últimas submissões para 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 05/02/2012 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/04/2012

    Estado do capital em 12/04/2012

    • Capital: GBP 120,762.69
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW em 10/04/2012

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Peter Maclean como diretor em 22/09/2011

    1 páginasTM01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed 5I LIMITED\certificate issued on 01/12/11
    2 páginasCERTNM
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Transfer share cap 22/09/2011
    RES13

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2010 para 30/06/2011

    1 páginasAA01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    1 páginasAD02

    Nomeação de Mb Secretaries Limited como secretário

    2 páginasAP04

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Declaração anual preparada até 05/02/2011 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Término da nomeação de Alastair Ferguson como secretário

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Alastair Ferguson como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    16 páginasAA

    Nomeação de Mr Alastair William Ferguson como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de David Hearn como secretário

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de David Hearn como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Alastair William Ferguson como diretor

    2 páginasAP01

    legacy

    5 páginasMG01

    Declaração anual preparada até 05/02/2010 com lista completa de acionistas

    12 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para David Gareth Hearn em 05/02/2010

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MB SECRETARIES LIMITED
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4813248
    124285230001
    ALLAN, Keith Andrew
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish100161360001
    BROWN, Richard William
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    Diretor
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish100161150001
    HOWELLS, Peter Hugh
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    Diretor
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    EnglandBritish163030330001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Secretário
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    154526830001
    HEARN, David Gareth
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    Secretário
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    British59462210001
    ORCHARD, Clive
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    British81052720003
    BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Secretário
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    74407280002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Diretor
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    EnglandBritish125179970001
    HEARN, David Gareth
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    Diretor
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    United KingdomBritish59462210001
    MACLEAN, Peter
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    Diretor
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    United KingdomBritish157773140001
    ORCHARD, Clive
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    Diretor
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    British81052720002
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    Diretor
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritish34690210001
    STEVENS, Terrence
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    Diretor
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    British81052700001
    BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Diretor
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    101374610001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 28/04/2010
    Entregue em 29/04/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account operated by field seymour parks as solicitors for the landlord under the lease pursuant to the terms of the said rent deposit deed.
    Pessoas com direito
    • Mulhern Properties Limited
    Transações
    • 29/04/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Fixed and floating charge
    Criado em 30/11/2007
    Entregue em 08/12/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 08/12/2007Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 15/09/2006
    Entregue em 19/09/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/09/2006Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 08/05/2006
    Entregue em 09/05/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All monies from time to time standing to the credit of the interest-bearing deposit account.
    Pessoas com direito
    • Mulhern Properties Limited
    Transações
    • 09/05/2006Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 18/02/2005
    Entregue em 22/02/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Venture Finance PLC Trading as Venture Factors
    Transações
    • 22/02/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rental deposit deed
    Criado em 08/04/2004
    Entregue em 23/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account pursuant to the terms of the rental deposit deed.
    Pessoas com direito
    • Mulhern Properties Limited
    Transações
    • 23/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 04/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 17/07/2002
    Entregue em 23/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £6,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The sum of £6,750.00.
    Pessoas com direito
    • Daceberry Limited
    Transações
    • 23/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 04/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0