G2 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaG2 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04390861
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de G2 LIMITED?

    • (7415) /

    Onde fica G2 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de G2 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    AIRTIME GROUP HOLDINGS LIMITED20/03/200220/03/2002
    DIGAME LIMITED08/03/200208/03/2002

    Quais são as últimas contas de G2 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para G2 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Contas de isenção total preparadas até 30/09/2010

    8 páginasAA

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 08/03/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account cancelled 23/02/2011
    RES13

    Estado do capital em 14/03/2011

    • Capital: GBP 1.00
    6 páginasSH19

    Contas de isenção total preparadas até 30/09/2009

    11 páginasAA

    Término da nomeação de Peter Smyth como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 08/03/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2008

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Contas anuais preparadas até 30/09/2007

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Quem são os diretores de G2 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Secretário
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Diretor
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Diretor
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secretário
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secretário
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secretário
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secretário
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secretário nomeado
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Diretor
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Diretor
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Diretor
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Diretor
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Diretor
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Diretor
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Diretor
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Diretor
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Diretor
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Diretor
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Diretor
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Diretor nomeado
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Diretor
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001

    G2 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Criado em 19/12/2005
    Entregue em 06/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 06/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Syndicated debenture
    Criado em 19/12/2005
    Entregue em 06/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 06/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 12/07/2005
    Entregue em 15/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 15/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 21/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Criado em 02/08/2002
    Entregue em 21/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 21/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 02/08/2002
    Entregue em 13/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or airtime interactive marketing LTD to the chargee on account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0