DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED

DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDORMANT COMPANY 04401645 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04401645
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4th Floor Cumberland House
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TRUSTMARQUE INTERMEDIARY LIMITED04/04/200204/04/2002
    BROOMCO (2861) LIMITED22/03/200222/03/2002

    Quais são as últimas contas de DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    15 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/12/2016

    8 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT para 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG em 05/12/2016

    2 páginasAD01

    Satisfação total da garantia 044016450008

    1 páginasMR04

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 14/12/2015

    • Capital: GBP 6,707,659
    3 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resolução de alteração dos direitos ou da designação das ações

    RES12

    Endereço do domicílio registado alterado de 1st Floor 100 Wood Street London EC2V 7AN para Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT em 04/01/2016

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 14/12/2015

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Término da nomeação de Martin John Trainer como diretor em 14/12/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Dermot James Joyce como diretor em 14/12/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Peter Charles Mills como secretário em 14/12/2015

    1 páginasTM02

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed trustmarque intermediary LIMITED\certificate issued on 11/12/15
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name11/12/2015

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Término da nomeação de James Christopher Michael Woolley como diretor em 03/12/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    13 páginasAA

    Término da nomeação de Neil Martin Simpson como diretor em 26/05/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 22/03/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital17/04/2015

    Estado do capital em 17/04/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr James Christopher Michael Woolley em 01/02/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Dermot James Joyce em 01/02/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Martin John Trainer em 01/02/2015

    2 páginasCH01

    Diversos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Detalhes do secretário alterados para Mr Peter Charles Mills em 02/02/2015

    1 páginasCH03

    Memorando e estatutos

    8 páginasMA

    Quem são os diretores de DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Secretário
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    British84739280002
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Secretário
    Triune Court
    Monks Cross Drive Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    167818470001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Secretário
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    British73646130001
    MILLS, Peter Charles
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Secretário
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    191203180001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretário nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BLOW, Bridget Penelope
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    Flat 119 B Central
    38 Paradise Street
    B1 2AF Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish115125670001
    COOKE, Ursula
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    Diretor
    70 Bootham
    YO30 7DF York
    British115125770002
    FERGUSON, Paul John
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    Diretor
    31 Strensall Road
    Huntington
    YO32 9SH York
    North Yorkshire
    EnglandBritish84739280002
    FINLAYSON, David John Mcintosh
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    British33124430005
    GODLIMAN, Victoria
    Triune Court
    Monks Cross Drive Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    Diretor
    Triune Court
    Monks Cross Drive Huntington
    YO32 9GZ York
    Trustmarque House
    Yorkshire
    England
    EnglandBritish83684440003
    HADDOW, Scott William
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8LY Knutsford
    Spinney End
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish121651070002
    JOYCE, Dermot James
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomIrish181301350001
    LIGERTWOOD, Mark Murray
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    Diretor
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomUk179214640001
    LLOYD, Colin Thomas
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    Diretor
    Fawke Common
    Underriver
    TN15 0JX Sevenoaks
    Fawke House
    Kent
    EnglandBritish3616430001
    METCALFE, Richard Crosby, Mr.
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    Diretor
    Ryehill Cottage
    Lyndhurst Road
    SO42 7YE Beaulieu
    Hampshire
    United KingdomBritish73646130001
    MILLER, Ross Charles
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    Diretor
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    EnglandBritish84739210001
    ROGERS, Christine Margaret
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Old Granary
    Chilton Road
    HP18 0DN Chearsley
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66374680002
    SIMPSON, Neil Martin
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    United KingdomBritish183192810001
    TRAINER, Martin John
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish124180840001
    WOOLLEY, James Christopher Michael
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish156851530001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Diretor nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Diretor nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 17/12/2014
    Entregue em 19/12/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transações
    • 19/12/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 01/06/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/07/2013
    Entregue em 19/07/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of trustmarque intermediary limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Senior Security Agent
    Transações
    • 19/07/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 09/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 07/06/2013
    Entregue em 14/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Dcg Nominees Limited (As Security Trustee)
    Transações
    • 14/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 09/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 12/08/2006
    Entregue em 18/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 29/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge of securities
    Criado em 12/08/2006
    Entregue em 18/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Its whole right title and benefit to the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 29/08/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 25/06/2002
    Entregue em 09/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank Investments Limited
    Transações
    • 09/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 23/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 05/06/2002
    Entregue em 11/06/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank Investments Limited
    Transações
    • 11/06/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 23/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 05/04/2002
    Entregue em 17/04/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank Investments Limited
    Transações
    • 17/04/2002Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 23/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    DORMANT COMPANY 04401645 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    14/12/2015Início da liquidação
    10/04/2018Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Stephen John Adshead
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Profissional
    Smith & Williamson Llp Imperial House
    18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Gregory Andrew Palfrey
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire
    Profissional
    Imperial House 18-21 Kings Park Road
    SO15 2AT Southampton
    Hampshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0