WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED

WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWESTERN WINES HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04485988
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Thomas Hardy House
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Surrey
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HAMSARD 2545 LIMITED27/08/200227/08/2002

    Quais são as últimas contas de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/06/2024
    Próximas contas vencem em31/03/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até15/07/2025
    Próxima declaração de confirmação vence29/07/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até15/07/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2023

    22 páginasAA

    legacy

    111 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Detalhes do diretor alterados para Mr Derek William Nicol em 26/02/2024

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Derek William Nicol como diretor em 15/02/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Caroline Thompson-Hill como diretor em 15/02/2024

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Tejvir Singh em 31/08/2023

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2022

    20 páginasAA

    legacy

    103 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Detalhes do diretor alterados para Ms Caroline Thompson-Hill em 23/08/2022

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Catherine Judith Shrimplin como diretor em 24/08/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2021

    21 páginasAA

    legacy

    103 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Detalhes do diretor alterados para Ms Caroline Thompson-Hill em 14/10/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Tejvir Singh em 20/10/2021

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Alastair David James Snook como diretor em 29/07/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Catherine Judith Shrimplin como diretor em 29/07/2021

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SINGH, Tejvir
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    256551660001
    NICOL, Derek William
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector262168800017
    SINGH, Tejvir
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianCompany Director256551570014
    CLOTHIER, Esther
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    162194340001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretário
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    BritishCompany Secretary28396500005
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Secretário
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    149220150001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    157430910002
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Secretário
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    BritishSolicitor69554640002
    RYAN, Julie Anne
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    209633630001
    SPENCER, Nicola Jane
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    Secretário
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    England
    180939140001
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    161850700001
    WOOD, Anthony Graham
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    248241710001
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretário nomeado
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900023720001
    BAMBERGER, Jonathan
    63 Admiral Road
    Toronto
    Ontario M5r 2lr
    Canada
    Diretor
    63 Admiral Road
    Toronto
    Ontario M5r 2lr
    Canada
    CanadaBritishExecutive Vp189830120001
    BROCKETT, Gavin Stuart
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaSouth AfricanAccountant167554030002
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmericanDirector130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Diretor
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritishCompany Secretary28396500005
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Diretor
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant157727790001
    EAST, Michael Joseph
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianCompany Director179426220001
    GABB, Roger Michael
    Woodlands Hall
    Glazeley
    WV16 6AB Bridgnorth
    Salop
    Diretor
    Woodlands Hall
    Glazeley
    WV16 6AB Bridgnorth
    Salop
    EnglandBritishWine & Spirit Merchant141310320001
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Diretor
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director137615160001
    GORST, Steven Lee
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    CanadaCanadianCompany Director180938750002
    HETTERICH, Francis Paul
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmericanCompany Director147054340001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianAccountant157415150002
    JONES, Richard
    58 Braeside Road
    Toronto
    Ontario M4n 1x7
    Canada
    Diretor
    58 Braeside Road
    Toronto
    Ontario M4n 1x7
    Canada
    CanadianExecutive Vice President Finan96543150001
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Diretor
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    AmericanDirector119928070001
    LEWIS, Alan Stuart
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    Diretor
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector139548580001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    Diretor
    The Guildway Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor69554640002
    MCKEON, Adrian Francis
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director, Ukir123271770001
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Diretor
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    AmericanCompany Director114902210001
    PAUL, Michael Anthony Keyes
    Upper Cound House
    SY5 6AX Cound
    Salop
    Diretor
    Upper Cound House
    SY5 6AX Cound
    Salop
    United KingdomBritishWine Importer106529070001
    RATCLIFFE, Robert John
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant185752460001
    RYAN, Julie Anne
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianSolicitor230311770001

    Quem são as pessoas com controle significativo de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Accolade Wines Europe No. 2 Limited
    Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    England
    06/04/2016
    Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    England
    Não
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroUk Register Of Companies
    Número de registro2715046
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 14/10/2016
    Entregue em 31/10/2016
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as New UK Security Trustee)
    Transações
    • 31/10/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 01/06/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 14/10/2016
    Entregue em 21/10/2016
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as UK Security Trustee)
    Transações
    • 21/10/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 01/06/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 18/10/2011
    Entregue em 25/10/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited (As UK Security Trustee)
    Transações
    • 25/10/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 01/06/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage of shares
    Criado em 30/03/2005
    Entregue em 18/04/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the bank facility agent, the collateral agent or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the shares and the interest in all shares, stocks, debentures, bonds, warrants, coupons or other securities and investments. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Bank of Nova Scotia as the Collateral Agent Under the Intercreditor Agreement for Thebenefited Parties
    Transações
    • 18/04/2005Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of paul letheren
    Criado em 09/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of stephen smith
    Criado em 09/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of anthony fairbank
    Criado em 09/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of jon woodriffe
    Criado em 09/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Own account assignment of life policy in respect of michael paul
    Criado em 09/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 03/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture ("composite debenture")
    Criado em 20/09/2002
    Entregue em 27/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transações
    • 27/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 08/11/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/09/2002
    Entregue em 30/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transações
    • 30/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 14/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0