WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 04485988 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Thomas Hardy House 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Surrey England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
HAMSARD 2545 LIMITED | 27/08/2002 | 27/08/2002 |
Quais são as últimas contas de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 30/06/2024 |
Próximas contas vencem em | 31/03/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 30/06/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Última declaração de confirmação elaborada até | 15/07/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 29/07/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 15/07/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2023 | 22 páginas | AA | ||
legacy | 111 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Derek William Nicol em 26/02/2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Nomeação de Mr Derek William Nicol como diretor em 15/02/2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Caroline Thompson-Hill como diretor em 15/02/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Tejvir Singh em 31/08/2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2022 | 20 páginas | AA | ||
legacy | 103 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Detalhes do diretor alterados para Ms Caroline Thompson-Hill em 23/08/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Término da nomeação de Catherine Judith Shrimplin como diretor em 24/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 30/06/2021 | 21 páginas | AA | ||
legacy | 103 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Detalhes do diretor alterados para Ms Caroline Thompson-Hill em 14/10/2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Tejvir Singh em 20/10/2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Término da nomeação de Alastair David James Snook como diretor em 29/07/2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mrs Catherine Judith Shrimplin como diretor em 29/07/2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Quem são os diretores de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGH, Tejvir | Secretário | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 256551660001 | |||||||
NICOL, Derek William | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey England | England | British | Director | 262168800017 | ||||
SINGH, Tejvir | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Company Director | 256551570014 | ||||
CLOTHIER, Esther | Secretário | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162194340001 | |||||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Secretário | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | Company Secretary | 28396500005 | |||||
GLENNIE, Helen Margaret | Secretário | The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey | 149220150001 | |||||||
HUGHES, David John | Secretário | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157430910002 | |||||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretário | The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey | British | Solicitor | 69554640002 | |||||
RYAN, Julie Anne | Secretário | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 209633630001 | |||||||
SPENCER, Nicola Jane | Secretário | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey England | 180939140001 | |||||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Secretário | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 161850700001 | |||||||
WOOD, Anthony Graham | Secretário | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | 248241710001 | |||||||
HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham West Midlands | 73037780002 | |||||||
HSE SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900023720001 | |||||||
BAMBERGER, Jonathan | Diretor | 63 Admiral Road Toronto Ontario M5r 2lr Canada | Canada | British | Executive Vp | 189830120001 | ||||
BROCKETT, Gavin Stuart | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | Accountant | 167554030002 | ||||
CHRISTENSEN, Troy | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | Director | 130789730003 | ||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Diretor | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | Company Secretary | 28396500005 | ||||
CREIGHTON, Thomas Hugh | Diretor | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | Accountant | 157727790001 | ||||
EAST, Michael Joseph | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Company Director | 179426220001 | ||||
GABB, Roger Michael | Diretor | Woodlands Hall Glazeley WV16 6AB Bridgnorth Salop | England | British | Wine & Spirit Merchant | 141310320001 | ||||
GLENNIE, Helen Margaret | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 137615160001 | ||||
GORST, Steven Lee | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Canada | Canadian | Company Director | 180938750002 | ||||
HETTERICH, Francis Paul | Diretor | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United States | American | Company Director | 147054340001 | ||||
HUGHES, David John | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Accountant | 157415150002 | ||||
JONES, Richard | Diretor | 58 Braeside Road Toronto Ontario M4n 1x7 Canada | Canadian | Executive Vice President Finan | 96543150001 | |||||
KLEIN, David | Diretor | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | Director | 119928070001 | |||||
LEWIS, Alan Stuart | Diretor | Farleigh Road Backwell BS48 3PE Bristol Southfield Farm North Somerset United Kingdom | England | British | Director | 139548580001 | ||||
LOUSADA, James David | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 152222000001 | ||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Diretor | The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 69554640002 | ||||
MCKEON, Adrian Francis | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | England | British | Regional Managing Director, Ukir | 123271770001 | ||||
MORAMARCO, Jon | Diretor | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | Company Director | 114902210001 | |||||
PAUL, Michael Anthony Keyes | Diretor | Upper Cound House SY5 6AX Cound Salop | United Kingdom | British | Wine Importer | 106529070001 | ||||
RATCLIFFE, Robert John | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Management Consultant | 185752460001 | ||||
RYAN, Julie Anne | Diretor | 2 Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 230311770001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accolade Wines Europe No. 2 Limited | 06/04/2016 | Heath Road KT13 8TB Weybridge Thomas Hardy House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
WESTERN WINES HOLDINGS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 14/10/2016 Entregue em 31/10/2016 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 14/10/2016 Entregue em 21/10/2016 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 18/10/2011 Entregue em 25/10/2011 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage of shares | Criado em 30/03/2005 Entregue em 18/04/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the lenders, the bank facility agent, the collateral agent or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All the shares and the interest in all shares, stocks, debentures, bonds, warrants, coupons or other securities and investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Own account assignment of life policy in respect of paul letheren | Criado em 09/10/2002 Entregue em 14/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Own account assignment of life policy in respect of stephen smith | Criado em 09/10/2002 Entregue em 14/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Own account assignment of life policy in respect of anthony fairbank | Criado em 09/10/2002 Entregue em 14/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Own account assignment of life policy in respect of jon woodriffe | Criado em 09/10/2002 Entregue em 14/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Own account assignment of life policy in respect of michael paul | Criado em 09/10/2002 Entregue em 14/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The life policy and all amounts (including bonuses) that are to be paid under it; and any amount to be paid to the company on cancellation of the life policy under section 76 of the insurance companies act 1982. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture ("composite debenture") | Criado em 20/09/2002 Entregue em 27/09/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 19/09/2002 Entregue em 30/09/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0