SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04502016
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    • Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED23/10/200223/10/2002
    SOUTHWEST LIMITED02/08/200202/08/2002

    Quais são as últimas contas de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012

    1 páginasTM02

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4

    Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 17/08/2012

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/08/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/08/2012

    Estado do capital em 14/08/2012

    • Capital: GBP 600,002
    SH01

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    4 páginas1.1

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    28 páginasAA

    Declaração anual preparada até 02/08/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Término da nomeação de William Mcleish como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Richard Midmer como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/08/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Contas anuais preparadas até 27/09/2009

    25 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kamma Foulkes como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Secretário
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Secretário
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305970001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secretário nomeado
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    ASARIA, Mohamed Saleem
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    Diretor
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    EnglandBritish13927880001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Diretor
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Diretor
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Diretor
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Diretor
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCQUAID, Michael James
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish89052830001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Diretor
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Diretor
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Diretor
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Diretor
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Diretor
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Diretor
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Diretor
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Diretor
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Diretor
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    Diretor
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    WILSON, Mark Stephen
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    Diretor
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    British90893350001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Diretor nomeado
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 07/05/2003
    Entregue em 15/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transações
    • 15/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 07/05/2003
    Entregue em 10/05/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transações
    • 10/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 10/05/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Rent deposit deed
    Criado em 29/04/2003
    Entregue em 09/05/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit the interest the deposit account and the deposit balance.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transações
    • 09/05/2003Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 29/04/2003
    Entregue em 08/05/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transações
    • 08/05/2003Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/04/2003
    Entregue em 02/05/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transações
    • 02/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 30/04/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/04/2003
    Entregue em 02/05/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transações
    • 02/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 30/04/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Rent deposit deed
    Criado em 24/03/2003
    Entregue em 03/04/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transações
    • 03/04/2003Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 24/03/2003
    Entregue em 27/03/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transações
    • 27/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 30/04/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Rent deposit deed
    Criado em 20/03/2003
    Entregue em 03/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transações
    • 03/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 20/03/2003
    Entregue em 25/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transações
    • 25/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 28/01/2003
    Entregue em 05/02/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transações
    • 05/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 10/05/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Rent deposit deed
    Criado em 28/01/2003
    Entregue em 01/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transações
    • 01/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Profissional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0