SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED

SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04524259
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até29/04/2018

    Quais são as últimas submissões para SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/01/2021

    10 páginasLIQ03

    Declaração de solvência

    4 páginasLIQ01

    legacy

    5 páginasRP04CS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom para Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU em 27/01/2020

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 16/01/2020

    LRESSP

    Estado do capital em 30/12/2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Share premium cancelled, amounts from reductions credited to p&l reserves 09/12/2019
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 04/09/2019 com atualizações

    5 páginasCS01
    Anotações
    DataAnotação
    31/01/2020Clarification A second filed CS01 (Statement of capital change) was registered on 31/01/2020.

    Estado do capital em 03/04/2019

    • Capital: GBP 200
    4 páginasSH02

    Contas anuais preparadas até 29/04/2018

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 04/09/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Nomeação de Mr Richard Smothers como diretor em 31/01/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 31/01/2018

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/04/2017

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 04/09/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 01/05/2016

    18 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 02/09/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 8

    21 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 6

    21 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 7

    17 páginasMR05

    Quem são os diretores de SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secretário
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    British92581040002
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Secretário
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    British64723790002
    LUCK, Richard Nigel
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    Secretário
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    British61070930001
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Secretário
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    ANAND, Rooney
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish77808680003
    ANGELA, Mark David
    Cockerells Hall
    Buxhall
    IP14 3DR Stowmarket
    Suffolk
    Diretor
    Cockerells Hall
    Buxhall
    IP14 3DR Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritish168009790001
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Diretor
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    United KingdomBritish64723790002
    BRIDGE, Timothy John Walter
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    Diretor
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    United KingdomBritish35576730001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish215065730001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Diretor
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish163139060001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Diretor
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish163139060001
    BULL, Ian Alan
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Diretor
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish210299090001
    DAVIS, Kirk Dyson
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Diretor
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    United KingdomBritish109155280002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Diretor
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    FORRESTER, Karen Martha
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    Diretor
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    EnglandBritish77261830001
    KING, Christopher
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    Diretor
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    British77423330001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    Diretor
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    British75831270003
    LOVERING, John David
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    Diretor
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritish73573160002
    PARKER, Raymond
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish86304880001
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Diretor
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritish78974110003
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Diretor
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritish78974110003
    SHALLOW, Michael St John
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    Diretor
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish31387250002

    Quem são as pessoas com controle significativo de SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    06/04/2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro5265451
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Second supplemental deed of charge
    Criado em 30/06/2008
    Entregue em 08/07/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Trustees (Ci) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transações
    • 08/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/2016Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    First supplemental borrower deed of charge
    Criado em 08/05/2006
    Entregue em 19/05/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligors to the borrower security trustee or any other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the properties as specified on the schedule to the form 395 and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transações
    • 19/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/2016Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    Deed of charge
    Criado em 07/03/2005
    Entregue em 22/03/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    1550 abbott redhill f/h SY641089,5350 abingdon arms wantage f/h ON245493,5220 acall estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixture,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property,the ancillary property rights, all rights,title,benefit and interest,to and under the relevant documents and the insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc (C.I) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transações
    • 22/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/2016Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    Twelfth supplemental trust deed supplemental to the trust deed dated 29 july 1991
    Criado em 06/08/2004
    Entregue em 13/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £86,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Pubco PLC and the Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transações
    • 13/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 27 may 1997
    Criado em 06/08/2004
    Entregue em 13/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £25,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transações
    • 13/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/12/2002
    Entregue em 31/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Nomura International PLC (As Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries)(as Defined)
    Transações
    • 31/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 23/08/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/10/2002
    Entregue em 21/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Coopers south bretton copelands peterborough PE3 8YB t/n CB165885, prospect hotel sunderland durham street SR3 4DF t/n DU21662, red lion darlington priestgate DL1 1NG t/n DU242698, for details of further properties charged please refer to the form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lehman Commercial Paper Inc. as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 21/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A third supplemental debenture which supplements a debenture dated 22 may 2001 and
    Criado em 06/09/2002
    Adquirido em 07/10/2002
    Entregue em 14/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due of each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The whole of the property, undertaking and assets constituting the sapphire number 1 rental business. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lehman Commercial Paper, Inc as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 14/10/2002Registro de uma aquisição (400)
    • 23/12/2002Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 02/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SAPPHIRE FOOD NORTH EAST NO.1 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    16/01/2020Início da liquidação
    25/04/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0