WHITE CORN LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWHITE CORN LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04542352
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WHITE CORN LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica WHITE CORN LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WHITE CORN LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EWM (TOPCO) LIMITED07/11/200607/11/2006
    THE EDINBURGH WOOLLEN MILL (GROUP) LIMITED26/02/200326/02/2003
    EWM TOPCO LIMITED11/11/200211/11/2002
    INTERCEDE 1816 LIMITED23/09/200223/09/2002

    Quais são as últimas contas de WHITE CORN LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até02/03/2019

    Quais são as últimas submissões para WHITE CORN LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    15 páginasLIQ14

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 19/07/2021

    LRESEX

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS United Kingdom para C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB em 04/08/2021

    2 páginasAD01

    Estado de situação patrimonial

    10 páginasLIQ02

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Término da nomeação de Carmel Leigh como diretor em 30/06/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Anthony Herring como diretor em 30/06/2021

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 045423520009

    1 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de Global House 5 Castle Street Carlisle Cumbria CA3 8SY England para 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS em 18/06/2021

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name14/06/2021

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Término da nomeação de Daniel Philip Day como diretor em 27/04/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Lauren Sarah Day como diretor em 27/04/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Philip Edward Day como diretor em 27/04/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/03/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de David Oliver Houston como diretor em 16/10/2020

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Daniel Philip Day como diretor em 15/09/2020

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr John Robert Jackson como diretor em 15/09/2020

    2 páginasAP01

    Registo da garantia 045423520009, criada em 24/08/2020

    19 páginasMR01

    Registo da garantia 045423520008, criada em 17/03/2020

    26 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 16/03/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas consolidadas preparadas até 02/03/2019

    68 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Miss Lauren Sarah Day em 01/11/2018

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Miss Lauren Sarah Day em 24/06/2016

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Robert Neil Edmonds como diretor em 07/06/2019

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de WHITE CORN LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CARRUTHERS, June
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    Secretário
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    British50519150001
    JACKSON, John Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Diretor
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    WalesBritish274337670001
    SIMPSON, Stephen Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Diretor
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    United KingdomBritish166820010002
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretário nomeado
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    DAY, Daniel Philip
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Diretor
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish226073480001
    DAY, Lauren Sarah
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Diretor
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish209763710001
    DAY, Philip Edward
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Diretor
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritish46992150038
    EDMONDS, Robert Neil
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Diretor
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    EnglandBritish206608930001
    GERRARD, Paul John
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    Diretor
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    UkBritish159694080001
    HERRING, John Anthony
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish151442360001
    HERRING, John Anthony
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    Diretor
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    EnglandBritish151442360001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Diretor
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    HOUSTON, David Oliver
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Diretor
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    ScotlandBritish75910100005
    HOUSTON, David Oliver
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    Diretor
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    ScotlandBritish75910100005
    LEE, Kristian Brian
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    Diretor
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    EnglandBritish160887440001
    LEIGH, Carmel
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish104858030003
    LIGHT, David Arthur
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    Diretor
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish45750750003
    WHITAKER, Alec
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    Diretor
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    EnglandBritish60593850003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Diretor nomeado
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001

    Quem são as pessoas com controle significativo de WHITE CORN LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    06/04/2016
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalScottish Law
    Local de registroCompanies House
    Número de registroSc307281
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) detêm, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) detêm, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    WHITE CORN LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 24/08/2020
    Entregue em 26/08/2020
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Not applicable.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Santander UK PLC
    Transações
    • 26/08/2020Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/07/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/03/2020
    Entregue em 17/03/2020
    Pendente
    Breve descrição
    The chargor charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any other land, investments, equipment, intellectual property, goodwill, uncalled capital, authorisations, insurances it holds in relation to any security asset.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited
    Transações
    • 17/03/2020Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 11/03/2019
    Entregue em 14/03/2019
    Pendente
    Breve descrição
    Not applicable.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transações
    • 14/03/2019Registro de uma garantia (MR01)
    Debenture
    Criado em 25/07/2011
    Entregue em 29/07/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) and each bilateral lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    (For details of all trade marks charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transações
    • 29/07/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 29/03/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating security document
    Criado em 31/10/2006
    Entregue em 08/11/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as the edinburgh wollen mill (group) limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transações
    • 08/11/2006Registro de uma garantia (395)
    • 27/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Criado em 25/02/2005
    Entregue em 04/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transações
    • 04/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 08/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Insurance assignment
    Criado em 14/05/2003
    Entregue em 16/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of its right title and interest present and future in and to the policies and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Insurance assignment
    Criado em 15/04/2003
    Entregue em 19/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The policies being 5 year bassett life policy number ASL19086 in the name of philip day for the sum of £1,000,000 commencement date 01/03/03, 5 year legal & general policy number 0088395306 in the name of alec whitaker for the sum of £250,000 commencement date 01/03/03. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transações
    • 19/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/11/2002
    Entregue em 20/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 20/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 02/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    WHITE CORN LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    19/07/2021Início da liquidação
    08/04/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Gordon Thomson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profissional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profissional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0