INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04644802 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | c/o G4S SPV Challenge House International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 30/09/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/06/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 01/01/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 15/01/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 01/01/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2026 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Christopher Edwin Walker como diretor em 14/10/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2024 | 3 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Andrew Philip Holland como secretário em 07/10/2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Término da nomeação de Georgina Claire Brown como secretário em 07/10/2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Giles James Frost como diretor em 19/12/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Hugh Luke Blaney como diretor em 19/12/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Stephen Gregory Minion como diretor em 01/11/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mrs Charlotte Sophie Ellen Douglass como diretor em 27/09/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Daniel Marinus Maria Vermeer como diretor em 27/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Richard Darch como diretor em 06/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mrs Georgina Claire Brown como secretário em 06/09/2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Término da nomeação de Andrew Philip Holland como secretário em 03/09/2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2020 | 3 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Andrew Philip Holland como secretário em 01/03/2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Término da nomeação de Daniel Peter Bevan como secretário em 01/03/2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Stephen Gregory Minion como diretor em 27/06/2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Quem são os diretores de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, Andrew Philip | Secretário | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | 328138910001 | |||||||
| ANDREWS, Paul Simon | Diretor | More London Riverside SE1 2AQ London 3 More London Riverside England | England | British | 119057120007 | |||||
| BLANEY, Hugh Luke | Diretor | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England | England | Irish | 79556770059 | |||||
| COOK, Allan Cameron | Diretor | More London Riverside SE1 2AQ London 3 More London Riverside England | United Kingdom | British | 125405420001 | |||||
| DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen | Diretor | International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | United Kingdom | British | 245967540001 | |||||
| FROST, Giles James | Diretor | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England | United Kingdom | British | 81910810001 | |||||
| WALKER, Christopher Edwin | Diretor | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | United Kingdom | British | 267835110001 | |||||
| BEVAN, Daniel Peter | Secretário | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | 253207550001 | |||||||
| BROWN, Georgina Claire | Secretário | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | 286948120001 | |||||||
| HOLLAND, Andrew Philip | Secretário | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | 280348430001 | |||||||
| POLLARD, Carolyn Jane | Secretário | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | 204165900001 | |||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secretário | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| BEVAN BRITTAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | 35 Colston Avenue BS1 4TT Bristol Avon | 101542850001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BLANEY, Hugh Luke | Diretor | 10 Dunmore Road Wimbledon SW20 8TN London | United Kingdom | Irish | 79556770002 | |||||
| CARROLL, Paul Bryan | Diretor | The Brew House Greenalls Avenue WA4 6HL Warrington Assura Group Limited United Kingdom | England | British | 85123780001 | |||||
| DARCH, Richard | Diretor | Upper Borough Walls BA1 1RG Bath Archus Limited, Northgate House England | England | British | 178693100001 | |||||
| DARCH, Richard | Diretor | Cliveden Office Village, Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Bucks United Kingdom | England | British | 178693100001 | |||||
| DARCH, Richard | Diretor | Beaufort House London Road BA1 6PZ Bath Avon | England | British | 88696540001 | |||||
| DICKSON, Peter Alan | Diretor | Pointer House Farm Langley Lane Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 13332510001 | ||||||
| DYER, Matthew Stephen | Diretor | 43 Wentworth Road Harborne B17 9SN Birmingham West Midlands | England | British | 127210860001 | |||||
| EBSWORTH, Martin Richard | Diretor | 116 Harrow Road NG8 1FN Nottingham Nottinghamshire | British | 119584110001 | ||||||
| FROST, Giles James | Diretor | Gorst Road SW11 6JB London 21 | United Kingdom | British | 81910810001 | |||||
| HARTSHORNE, David John Morice | Diretor | Cliveden Office Village, Lancaster Road Cressex Business Park HP12 3YZ High Wycombe 6 Bucks United Kingdom | England | British | 87382740001 | |||||
| HATHAWAY, James Andrew John | Diretor | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | England | British | 129270110001 | |||||
| HOLMES, Jonathan | Diretor | 9 Holly Close Farnham Common SL2 3QT Slough | England | British | 107261280002 | |||||
| HOOD, John | Diretor | Briarwood 15 Twatling Road Barnt Green B45 8HX Birmingham West Midlands | British | 39644740001 | ||||||
| MCPHERSON, Andrew Robert | Diretor | 3 Lymmbrook House Whitbarrow Road WA13 9A Lymm Cheshire | British | 98108070001 | ||||||
| MINION, Stephen Gregory | Diretor | c/o G4s Spv International Drive Tewkesbury Business Park GL20 8UQ Tewkesbury Challenge House England | United Kingdom | British | 201775990001 | |||||
| MINION, Stephen Gregory | Diretor | Stomp Road Burnham SL1 7LW Slough The Priory Berkshire | England | British | 40537330005 | |||||
| PAPE, Christopher Robert Crawford | Diretor | 8 High Bannerdown Batheaston BA1 7JY Bath North East Somerset | British | 97813200001 | ||||||
| PARKER, David | Diretor | 4 Littledown Avenue BH7 7AN Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 70697550001 | |||||
| POKORA, David Bernard | Diretor | 30 Pitchens End SN4 9PR Broad Hinton Wiltshire | United Kingdom | British | 63190500001 | |||||
| RAWLINGS, Nigel Keith | Diretor | 18 Hollin Lane SK9 4JH Styal Cheshire | England | British | 7127460001 | |||||
| SAVAGE, Mark James | Diretor | 23 Godwin Drive Nailsea BS48 2XE Bristol Avon | British | 96884460001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de INFRACARE (MIDLANDS) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infracare Capital Limited | 22/01/2017 | Wellington Road Cressex Business Park HP12 3PS High Wycombe Unit 1 Barnes Wallis Court England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Equitix Infrastructure 3 Limited | 22/01/2017 | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0