JMC. IT GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJMC. IT GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04667713
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JMC. IT GROUP LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica JMC. IT GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    40 Bernard Street
    WC1N 1LE London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JMC. IT GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COBCO (570) LIMITED17/02/200317/02/2003

    Quais são as últimas contas de JMC. IT GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2017

    Quais são as últimas submissões para JMC. IT GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    legacy

    11 páginasRP04CS01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 24/12/2018

    • Capital: GBP 74,500.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account and capital redemption reserve 24/12/2018
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 01/05/2015

    • Capital: GBP 74,500
    3 páginasSH01

    Nomeação de Mr Geoffrey Christopher Yates-Kneen como diretor em 30/11/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Ryan Thomas Styles como diretor em 28/09/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/09/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Big Studios 1 East Poultry Avenue London EC1A 9PT para 40 Bernard Street London WC1N 1LE em 09/04/2018

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Andrew David Paul Insley como diretor em 08/02/2018

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2017

    14 páginasAA

    Término da nomeação de David Richard Mezher como diretor em 10/11/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/09/2016 com atualizações

    6 páginasCS01
    Anotações
    DataAnotação
    14/01/2019Clarification A second filed CS01 (statement of capital change, trading status of shares change, and shareholder information change) was registered on 14/01/2019.

    Contas anuais preparadas até 31/03/2016

    13 páginasAA

    Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/04/2016 para 31/03/2016

    1 páginasAA01

    Nomeação de Mr David Richard Mezher como diretor em 11/10/2016

    2 páginasAP01

    Satisfação total da garantia 046677130007

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 046677130008

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 046677130006

    4 páginasMR04

    Resoluções

    Resolutions
    15 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Quem são os diretores de JMC. IT GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    INSLEY, Andrew David Paul
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    Diretor
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer158086020001
    SWEETBAUM, Peter Mark
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    Diretor
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    EnglandAmericanChief Executive200178150001
    YATES-KNEEN, Geoffrey Christopher
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    Diretor
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    EnglandBritishDirector205973410001
    GILL, David
    8 Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    Manchester
    Secretário
    8 Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    Manchester
    British91363310001
    HOWARD, Rosa
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    Secretário
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    198448780001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Secretário nomeado
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    900006440001
    BENTLEY, Michael James
    Riverside
    Agecroft Road
    M27 8SJ Swinton
    Manchester
    Diretor
    Riverside
    Agecroft Road
    M27 8SJ Swinton
    Manchester
    United KingdomBritishDirector91340350004
    BUCHAN, George Allan
    White Lodge
    3 Whitehall Road
    M33 3WJ Sale
    Cheshire
    Diretor
    White Lodge
    3 Whitehall Road
    M33 3WJ Sale
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector5639810002
    BURGESS, Andrew Colin
    2 Gleneagles Way
    BL0 9QN Ramsbottom
    Lancashire
    Diretor
    2 Gleneagles Way
    BL0 9QN Ramsbottom
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director198565320001
    GILL, David
    8 Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    Manchester
    Diretor
    8 Bradgreen Road
    M30 8BZ Monton
    Manchester
    EnglandBritishFinancial Controller91363310001
    GRAY, Sebastian Christopher
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    Diretor
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    United KingdomBritishCompany Director80251590005
    HOWARD, Rosa Kathleen
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    Diretor
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    England
    EnglandBritishCompany Director126564410001
    ISHERWOOD, Nicholas Jonathan
    37 Kiers Court
    Arcon Village Horwich
    BL6 6TN Bolton
    Lancashire
    Diretor
    37 Kiers Court
    Arcon Village Horwich
    BL6 6TN Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector91340110006
    JONES, Robert Powis
    223 Mosley Common Road
    Worsley
    M28 1SF Manchester
    Lancashire
    Diretor
    223 Mosley Common Road
    Worsley
    M28 1SF Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director114639940001
    MAXWELL, Timothy Charles
    232 Broad Lane
    Burnedge Lane
    OL16 4PR Rochdale
    Lancashire
    Diretor
    232 Broad Lane
    Burnedge Lane
    OL16 4PR Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector91340020001
    MEZHER, David Richard
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    Diretor
    1 East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    Big Studios
    EnglandBritishDirector164206050001
    STEELE, Lauren
    1 Hamilton Mews
    St Anns Road Prestwich
    M25 9LE Manchester
    Lancashire
    Diretor
    1 Hamilton Mews
    St Anns Road Prestwich
    M25 9LE Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director124040990001
    STYLES, Ryan Thomas
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    Diretor
    Bernard Street
    WC1N 1LE London
    40
    England
    EnglandAustralianFinance Director210790140001
    SYKES, Malcolm
    31 Parsons Drive
    Middleton
    M24 5DJ Manchester
    Lancashire
    Diretor
    31 Parsons Drive
    Middleton
    M24 5DJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishDirector32256900001
    TOBIN, Paul Denis
    Linnyshaw Farmhouse
    East Lynn Drive
    M28 3WF Worsley
    Lancashire
    Diretor
    Linnyshaw Farmhouse
    East Lynn Drive
    M28 3WF Worsley
    Lancashire
    EnglandBritishDirector32246840003
    COBBETTS LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Diretor nomeado
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    900006430001

    Quem são as pessoas com controle significativo de JMC. IT GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    It Lab Ltd
    East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    1
    England
    06/04/2016
    East Poultry Avenue
    EC1A 9PT London
    1
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroUk Companies House
    Número de registro03645998
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    JMC. IT GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 22/12/2015
    Entregue em 07/01/2016
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Trademark no's 2494542 and 2494493.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Five Arrows Managers S.A.
    Transações
    • 07/01/2016Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/08/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/05/2015
    Entregue em 07/05/2015
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Five Arrows Managers S.A.
    Transações
    • 07/05/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/08/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/05/2015
    Entregue em 07/05/2015
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Andrew Colin Burgess
    Transações
    • 07/05/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/08/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 19/12/2006
    Entregue em 21/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 21/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 05/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 19/12/2006
    Entregue em 21/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 21/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 05/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal mortgage
    Criado em 01/08/2003
    Entregue em 06/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    50890 jmc group limited ordinary shares of £1.00 each fully paid all dividends interest of other distributions paid or payable in respect of them. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 06/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/07/2003
    Entregue em 26/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 26/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 16/07/2003
    Entregue em 23/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the loan note holders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Paul Denis Tobin as Security Agent and Trustee for the Loan Note Holders (The Security Trustee)
    Transações
    • 23/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0