EMLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaEMLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social, isenção de uso de 'Limited'
    Número da empresa 04813638
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de EMLC?

    • Serviços de apoio à educação (85600) / Educação

    Onde fica EMLC?

    Endereço do escritório registrado
    Mha Macintyre Hudson 6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de EMLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EAST MIDLANDS LEADERSHIP CENTRE 22/10/200322/10/2003
    THE EAST MIDLANDS AFFILIATED CENTRE27/06/200327/06/2003

    Quais são as últimas contas de EMLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2018

    Quais são as últimas submissões para EMLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    18 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/09/2020

    24 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ para Mha Macintyre Hudson 6th Floor, 2 London Wall Place London EC2Y 5AU em 22/01/2020

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Bridge House Bridge Street Olney MK46 4AB para New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ em 02/10/2019

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 16/09/2019

    LRESEX

    Estado de situação patrimonial

    8 páginasLIQ02

    Todo o bem ou empresa foi libertado e já não faz parte da garantia 2

    7 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado e já não faz parte da garantia 1

    7 páginasMR05

    Término da nomeação de Sheila Eileen Cowley como secretário em 11/07/2019

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 25/05/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Ms Jacqueline Rothery como diretor em 11/12/2018

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2018

    32 páginasAA

    Término da nomeação de Cathryn Helen Henry como diretor em 23/07/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/05/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2017

    34 páginasAA

    Término da nomeação de George Arthur Gyte como diretor em 31/10/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de William Thomas Adams como diretor em 12/10/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/05/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Nomeação de Mr Andy Phillip Chew como diretor em 15/09/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Cathryn Helen Henry como diretor em 15/09/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Richard James Moyse como diretor em 16/09/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Jacqueline Elizabeth Adams como diretor em 16/09/2016

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2016

    38 páginasAA

    Quem são os diretores de EMLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ADAMS, Jacqueline Elizabeth
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    Diretor
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    EnglandBritishHr Director217015850001
    BRISCOE, Robert John
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    Diretor
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    EnglandBritishEducation Adviser/Consultant88554790001
    CHEW, Andy Phillip
    Nettleden Road
    Little Gaddesden
    HP4 1PP Berkhamsted
    Woodridge
    England
    Diretor
    Nettleden Road
    Little Gaddesden
    HP4 1PP Berkhamsted
    Woodridge
    England
    EnglandBritishExecutive In It Industry217094790001
    MOYSE, Richard James
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    Diretor
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    Grest BritainBritishHead Of Corporate Relations217016040001
    ROTHERY, Jacqueline
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    Diretor
    6th Floor,
    2 London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    Mha Macintyre Hudson
    EnglandBritishEducation Consultant172950060002
    BOLLINGTON, Robert
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Secretário
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    British148987140001
    COWLEY, Sheila Eileen
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Buckinghamshire
    England
    Secretário
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Buckinghamshire
    England
    181734730001
    EVANS, Julie
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Secretário
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    171428380001
    GROOM, Mary Josephine
    24 Normandy Avenue
    EN5 2JA High Barnet
    Hertfordshire
    Secretário
    24 Normandy Avenue
    EN5 2JA High Barnet
    Hertfordshire
    British258468500001
    JEFFERY, Ian Stuart
    Spohr
    Hardwick Village
    NN9 5AL Wellingborough
    Northamptonshire
    Secretário
    Spohr
    Hardwick Village
    NN9 5AL Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector104118580001
    PEARSON, Elizabeth Anne
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Secretário
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    176045210001
    ADAMS, William Thomas, Reverend
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    EnglandBritishRetired184822080001
    ALLCOTT, Terry, Doctor
    Rainbow Cottage
    High Street, Walton
    LE17 5RG Lutterworth
    Leicestershire
    Diretor
    Rainbow Cottage
    High Street, Walton
    LE17 5RG Lutterworth
    Leicestershire
    BritishTrade Union Official90644640001
    ANDERSON, Elinor Jean
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    ScotlandBritishDirector Management Consultant140764200001
    BAGILHOLE, Rupert Thomas
    White Lodge
    34 Sandown Road
    LE2 2BJ Stoneygate
    Leicester
    Diretor
    White Lodge
    34 Sandown Road
    LE2 2BJ Stoneygate
    Leicester
    United KingdomBritishHeadteacher152627250001
    BATESON, David John
    Tapton Hall Barn
    S43 1QQ Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    Tapton Hall Barn
    S43 1QQ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishHeadteacher95579570001
    BERWICK, George Thomas
    35 Leigh Cliff Road
    SS9 1DJ Leigh On Sea
    Essex
    Diretor
    35 Leigh Cliff Road
    SS9 1DJ Leigh On Sea
    Essex
    United KingdomBritishHeadteacher67411740002
    CROMPTON, Kevin George
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    EnglandBritishCompany Director138923240001
    EAVES, Mark Stephen
    59 Rubery Field Close
    B45 9WD Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    59 Rubery Field Close
    B45 9WD Birmingham
    West Midlands
    BritishEducation Advisor121844250001
    EAVES, Mark Stephen
    59 Rubery Field Close
    B45 9WD Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    59 Rubery Field Close
    B45 9WD Birmingham
    West Midlands
    BritishEducation Officer121844250001
    ESAM, Marihelen
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    United KingdomBritishVisiting Fellow Cranfield176942530001
    FAIRLIE, James
    Rosslyn Crescent
    HA1 2SU Harrow
    Pin Point
    Middlesex
    England
    Diretor
    Rosslyn Crescent
    HA1 2SU Harrow
    Pin Point
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director177701140001
    GYTE, George Arthur
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    EnglandBritishEducation Consultant87651050003
    HAYES, Edward John
    13 Firs Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9GU Leicester
    Leicestershire
    Diretor
    13 Firs Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9GU Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector Of Education38107810001
    HENRY, Cathryn Helen
    Mount Keen
    SG1 6BP Stevenage
    19
    England
    Diretor
    Mount Keen
    SG1 6BP Stevenage
    19
    England
    EnglandBritishBusiness Owner181679960001
    HERBERT, Michael John
    1 Drake Way
    LE10 1UW Hinckley
    Leicestershire
    Diretor
    1 Drake Way
    LE10 1UW Hinckley
    Leicestershire
    United KingdomBritishRetired60823890001
    JEFFERY, Ian Stuart
    Spohr
    Hardwick Village
    NN9 5AL Wellingborough
    Northamptonshire
    Diretor
    Spohr
    Hardwick Village
    NN9 5AL Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector104118580001
    LIDDINGTON, Bruce, Sir
    2 The Elms 1a Green Lane
    Wolverton
    MK12 5HB Milton Keynes
    Diretor
    2 The Elms 1a Green Lane
    Wolverton
    MK12 5HB Milton Keynes
    EnglandBritishAdvisor52241270001
    LIDDINGTON, Carol Jane
    Green Lane
    Wolverton
    MK12 5HB Milton Keynes
    1a
    United Kingdom
    Diretor
    Green Lane
    Wolverton
    MK12 5HB Milton Keynes
    1a
    United Kingdom
    United KingdomUk/UsSolicitor/Judge152182960001
    MARTIN, Janice Rosalind
    80 Main Road
    Duston
    NN5 6JN Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    80 Main Road
    Duston
    NN5 6JN Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishLea Officer96110410001
    MCCORMICK, Anne Elizabeth
    Chestnut Avenue
    MK40 4HA Bedford
    Queens Park Lower School
    Bedofrdshire
    Diretor
    Chestnut Avenue
    MK40 4HA Bedford
    Queens Park Lower School
    Bedofrdshire
    UkBritishHead Teacher56043310001
    MORRIS, Derek James David
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    Diretor
    Bridge Street
    MK46 4AB Olney
    Bridge House
    EnglandBritishAdvertising And Media37395320002
    O'SULLIVAN, Fergus James
    5 Stenigot Grove
    Doddington Park
    LN6 3PF Lincoln
    Diretor
    5 Stenigot Grove
    Doddington Park
    LN6 3PF Lincoln
    BritishUniversity Lecturer90644620001
    OLIVER, Stephen John
    Orchard Lane
    Wyaston
    DE6 2DR Ashbourne
    Wyaston House
    Derbyshire
    England
    Diretor
    Orchard Lane
    Wyaston
    DE6 2DR Ashbourne
    Wyaston House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director152220640001
    SANDERSON, Michael David, Dr
    31 Murray Mews
    NW1 9RH London
    Diretor
    31 Murray Mews
    NW1 9RH London
    EnglandBritishEngineer24829640001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para EMLC?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    25/05/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    EMLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 09/07/2009
    Entregue em 16/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2019Todo o imóvel ou empresa foi liberado e não mais faz parte da garantia (MR05)
    Legal charge
    Criado em 09/07/2009
    Entregue em 11/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Bridge house bridge street olney buckinghamshire t/no BM250945; any other interest in the property, the goodwill of any business carried on at the property, proceeds of any insurance affecting the property, all plant and machinery, equipment, furniture, tools and other goods kept at the property. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 11/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2019Todo o imóvel ou empresa foi liberado e não mais faz parte da garantia (MR05)

    EMLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    24/02/2022Data de dissolução
    16/09/2019Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Georgina Marie Eason
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Profissional
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Michael Colin John Sanders
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Profissional
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0