OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04824858
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
    • Administração de imóveis por conta de terceiros (68320) / Atividades imobiliárias

    Onde fica OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2012

    Quais são as últimas submissões para OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2018

    7 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2017

    7 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP para 15 Canada Square London E14 5GL em 20/10/2016

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/09/2016

    LRESSP

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    47 páginas1.4

    Nomeação de Mr Richard James Spencer como diretor em 04/06/2015

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Brett Alan Lashley como diretor em 04/06/2015

    2 páginasTM01

    Nomeação de Brett Alan Lashley como diretor em 25/02/2015

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Craig Allan Mellor como diretor em 25/02/2015

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Gavin Robert Duncan como diretor em 25/02/2015

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Criag Allan Mellor como secretário em 25/02/2015

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Stuart Barrie Wall como diretor em 25/02/2015

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB para The Place Ducie Street Manchester M1 2TP em 06/03/2015

    2 páginasAD01

    Aviso de término da administração

    74 páginas2.32B

    Relatório de progresso do administrador até 10/01/2015

    67 páginas2.24B

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    9 páginas1.1

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 10/07/2014

    90 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 10/01/2014

    65 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 17/09/2013

    77 páginas2.24B

    Quem são os diretores de OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SPENCER, Richard James
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    Diretor
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    DRAPER, Abigail Sarah
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    Secretário
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    British107928180001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secretário nomeado
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MELLOR, Criag Allan
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    Secretário
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    British100890520001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Diretor
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Diretor
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Diretor
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Diretor
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Diretor nomeado
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Group debenture
    Criado em 04/04/2012
    Entregue em 19/04/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transações
    • 19/04/2012Registro de uma garantia (MG01)
    Legal charge
    Criado em 07/05/2004
    Entregue em 11/05/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transações
    • 11/05/2004Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 26/09/2003
    Entregue em 10/10/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 10/10/2003Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 12/09/2003
    Entregue em 25/09/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 25/09/2003Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 12/09/2003
    Entregue em 25/09/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 25/09/2003Registro de uma garantia (395)

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    18/03/2013Início da administração
    20/02/2015Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profissional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    12/12/2014Data da reunião para aprovar o CVA
    22/10/2015Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    DataTipo
    30/09/2016Início da liquidação
    22/08/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0