SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04958135 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SCOTIA GAS NETWORKS PLC | 27/05/2005 | 27/05/2005 |
| SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED | 09/02/2005 | 09/02/2005 |
| SCOTARIO LIMITED | 27/08/2004 | 27/08/2004 |
| SOUTH OF ENGLAND GAS DISTRIBUTION LIMITED | 24/05/2004 | 24/05/2004 |
| DUNWILCO (1109) LIMITED | 10/11/2003 | 10/11/2003 |
Quais são as últimas contas de SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/03/2026 |
| Próximas contas vencem em | 31/12/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 10/12/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 24/12/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 10/12/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 10/12/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Nicola Anne Shand como secretário em 06/11/2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2025 | 148 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Afonso Castello-Branco Gois como diretor em 16/05/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Mathew David Turnell-Henry como diretor em 16/05/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Felipe Ortiz como diretor em 08/05/2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Notificação de Bsip Uk Holdco Limited como pessoa com controlo significativo em 25/07/2019 | 2 páginas | PSC02 | ||
Alteração dos detalhes de Bsip Uk Holdco Limited como pessoa com controlo significativo em 14/05/2025 | 3 páginas | PSC05 | ||
Notificação de Braeburn Equityco Limited como pessoa com controlo significativo em 28/02/2025 | 2 páginas | PSC02 | ||
Alteração dos detalhes de Uk Gas Distribution 2 Limited como pessoa com controlo significativo em 15/04/2025 | 3 páginas | PSC05 | ||
Nomeação de Mr Fungai Makoni como secretário em 01/04/2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Nomeação de Mr David Demes como diretor em 30/01/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr James Alexander Adam como diretor em 30/01/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Megan Rose Birtwistle como secretário em 15/01/2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/12/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Christian Herbert Fingerle como diretor em 13/09/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2024 | 154 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Charles Thomazi como diretor em 12/06/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Antoine Jean René Kerrenneur como diretor em 15/04/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Matthew Jonathan Gross como diretor em 04/01/2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/12/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Miss Megan Rose Birtwistle como secretário em 01/11/2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Término da nomeação de Sharmila Virginia Sylvester como secretário em 01/11/2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/03/2023 | 130 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Antoine Jean René Kerrenneur como diretor em 29/03/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Quem são os diretores de SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKONI, Fungai | Secretário | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 334490580001 | |||||||
| ADAM, James Alexander | Diretor | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | England | British,Canadian | 195244550005 | |||||
| BOTHA, Michael John | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Canada | Canadian | 294271520001 | |||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Diretor | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||
| CATCHPOLE, Martin Paul | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | British | 285580440001 | |||||
| DEMES, David | Diretor | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | United Kingdom | Slovak | 334083960001 | |||||
| GOIS, Afonso Castello-Branco | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | Portuguese | 335866770001 | |||||
| GROSS, Matthew Jonathan | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United States | American | 318295020001 | |||||
| LUMLOCK, Rebecca Elizabeth | Diretor | One Canada Square, 25th Floor Canary Wharf E14 5AA London Brookfield United Kingdom | United Kingdom | British | 294141090001 | |||||
| ROSENTHAL, Jeffrey | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Canada | Canadian | 297967760001 | |||||
| SALMON, Nicholas Robin | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | British | 256613430001 | |||||
| SMART, Michael Oswald | Diretor | 2 St. James's Market SW1Y 4AH London Stepstone Group England | United Kingdom | British | 296382310001 | |||||
| TRIMMER, Paul John Vincent | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | British | 149695050001 | |||||
| TURNELL-HENRY, Mathew David | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | British | 335866750001 | |||||
| ADAMS, Jonathan Jeffrey | Secretário | Station Approach RH6 9HJ Horley St. Lawrence House Surrey United Kingdom | British | 150782130001 | ||||||
| BIRTWISTLE, Megan Rose | Secretário | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 315945900001 | |||||||
| GRAY, Ailsa Mary | Secretário | 27 Saint Magdalenes Road PH2 0BT Perth | British | 52995340008 | ||||||
| HARDING, Debbie Mary | Secretário | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House, 200 | British | 136476220001 | ||||||
| SHAND, Nicola Anne | Secretário | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | British | 162590670001 | ||||||
| SYLVESTER, Sharmila Virginia | Secretário | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 290375600001 | |||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Diretor | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Diretor | 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London The Leadenhall Building United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||
| COVASSIN, Tanya Maria | Diretor | 31 Anderson Avenue M5P 1H5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 103424270002 | ||||||
| DOWD, Stephen Donald | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Ontario, Canada | Canadian | 235050150001 | |||||
| FINGERLE, Christian Herbert, Dr | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Germany | German | 193691880001 | |||||
| FLAGEUL, Natalie Michaela | Diretor | Langstone Technology Park Langstone Road PO9 1SA Havant Sse Buliding 500 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164470090002 | |||||
| FLEMING, Neil Patrick | Diretor | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 201061840001 | |||||
| FRIEDRICHSEN, Adam Michael Cooper | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | Canadian | 285245290001 | |||||
| GRUND, Ines | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | German | 250793730001 | |||||
| HOOD, Colin William | Diretor | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Perthshire | United Kingdom | British | 80184130003 | |||||
| JUGGINS, Graham Gerald | Diretor | 4 Langley Place PH2 7XB Perth Perthshire | British | 103424030001 | ||||||
| KERRENNEUR, Antoine Jean René | Diretor | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | French | 308289130001 | |||||
| LAMBERT, Guy | Diretor | Corniche Street PO BOX 3600 211 Abu Dhabi United Arab Emirates | United Arab Emirates | Dutch | 218197910001 | |||||
| LEPIN, Ronald Kenneth | Diretor | 66 Howland Avenue Upper Floor M5R 3B3 Toronto Ontario M5r 3b3 Canada | Canadian | 100256500001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braeburn Equityco Limited | 28/02/2025 | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Uk Gas Distribution 2 Limited | 22/03/2022 | 22 Grenville Street JE4 8PX Jersey 22 Grenville Street, St Helier, Je4 8px, Jersey Jersey | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Bsip Uk Holdco Limited | 25/07/2019 | 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 Bartholomew Lane, London, England, Ec2n 2ax England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Sse Plc | 06/04/2016 | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0