LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 04996908 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
- Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias
Onde fica LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 100 Victoria Street SW1E 5JL London England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
HERMES FREEPORT GP LIMITED | 16/12/2003 | 16/12/2003 |
Quais são as últimas contas de LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/08/2019 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessação de Ls Outlets No 1 Gp Limited como pessoa com controlo significativo em 23/11/2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notificação de Land Securities Spv's Limited como pessoa com controlo significativo em 23/11/2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2018 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/08/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Louise Miller como diretor em 01/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Elizabeth Miles como diretor em 01/01/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2017 para 31/03/2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 24/10/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 47 páginas | AA | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Hermes Factory Outlets Gp Limited como pessoa com controlo significativo em 26/05/2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de alteração do nome" | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Término da nomeação de Hermes Secretariat Limited como secretário em 15/05/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Término da nomeação de Paul Thomas Wray como diretor em 15/05/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Christopher Raymond Andrew Darroch como diretor em 15/05/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Ls Director Limited como diretor em 15/05/2017 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Nomeação de Louise Miller como diretor em 15/05/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ls Company Secretaries Limited como secretário em 15/05/2017 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Nomeação de Land Securities Management Services Limited como diretor em 15/05/2017 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Hermes Administration Services Ltd Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ para 100 Victoria Street London SW1E 5JL em 18/05/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Quem são os diretores de LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
MILES, Elizabeth | Diretor | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 235498150001 | ||||||||
LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Diretor | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
LS DIRECTOR LIMITED | Diretor | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
HERMES SECRETARIAT LIMITED | Secretário | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers United Kingdom |
| 93700910001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
AGNEW, Julian Michael | Diretor | Cavendish Square W1A 2NF London 33 | England | British | Investment Manager | 151724030002 | ||||||||
DARROCH, Christopher Raymond Andrew | Diretor | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Scotland | British | Chartered Surveyor | 81530460007 | ||||||||
DEWHIRST, Andrew David | Diretor | 59 Old Park View EN2 7EQ Enfield Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 29539910003 | ||||||||
EVANS, Alasdair David | Diretor | 8 Copsem Lane KT10 9EU Esher Treaton Mill Surrey | United Kingdom | British | Director | 130019430001 | ||||||||
MARTIN, Andrew John, Mr. | Diretor | Hazelryst Rystwood Road RH18 5LX Forest Row East Sussex | England | British | Chartered Surveyor | 3565840001 | ||||||||
MILLER, Louise | Diretor | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 199935770001 | ||||||||
MOUSLEY, Emily Ann | Diretor | Flat C, 1 Cranley Gardens, Muswell Hill N10 3AA London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 155262770001 | ||||||||
TILL, Paul Richard | Diretor | Cavendish Square W1A 2NF London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Asset Manager | 69536070004 | ||||||||
WRAY, Paul Thomas | Diretor | 15 Coulters Close Grove Green ME14 5SU Maidstone Kent | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 154681480001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Spv's Limited | 23/11/2018 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Ls Outlets No 1 Gp Limited | 06/04/2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Criado em 20/12/2004 Entregue em 30/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The f/h land k/a land lying to the north west of charter way braintree t/no's EX632902 and EX603735 the f/h land k/a freeport retails village tomahawk trail castleford t/n WYK708788 and WYK710458 the l/h land k/a freeport village amounderness way fleetwood t/n LA845311 all buildings fixtures fixed plant and machinery its goodwill uncalled capital its book and other debts by way of a first floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge over partnership interest | Criado em 12/03/2004 Entregue em 25/03/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido This document was updated against this company in error and should have gone against the record of hermes factory outlets gp limited 4996883 | |
Breve descrição This document was updated against this company in error and should have gone against the record of hermes factory outlets gp limited 4996883. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating security document | Criado em 12/03/2004 Entregue em 25/03/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the security trustee, as agent for the lenders or the security trustee and/or possfund custodian trustee limited (together "the lenders") under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Freeport village braintree braintree essex t/ns EX603735 and EX632902 freeport village fleetwood fleetwood lancashire t/n LA845311 freeport village castleford yorkshire t/ns WYK708788 and WYK710458. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0