BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD

BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05089367
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    • Compra e venda de imóveis próprios (68100) / Atividades imobiliárias

    Onde fica BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BLACKPOOL AIRPORT HOLDINGS LIMITED11/06/200411/06/2004
    MEAUJO (661) LIMITED31/03/200431/03/2004

    Quais são as últimas contas de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2020

    Quais são as últimas submissões para BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/12/2020

    3 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ England para Mark Rebbeck - the Square Sc Management Office 18 Town Square Sale M33 7WZ em 27/08/2021

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/03/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2019

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/03/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2018

    10 páginasAA

    Término da nomeação de Michael James Brown como diretor em 01/07/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/03/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2017

    10 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/03/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2016

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/03/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/12/2015

    10 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/03/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/05/2016

    Estado do capital em 18/05/2016

    • Capital: GBP 783,654
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Wolverhampton Halfpenny Green Airport Stourbridge West Midlands DY7 5DY para C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ em 28/01/2016

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2014

    8 páginasAA

    Satisfação total da garantia 2

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 1

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 050893670004

    4 páginasMR04

    Nomeação de Mr Michael James Brown como diretor em 11/05/2015

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 31/03/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital31/03/2015

    Estado do capital em 31/03/2015

    • Capital: GBP 783,654
    SH01

    Quem são os diretores de BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MURPHY, Noel Ferris
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    England
    Secretário
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    England
    154493510001
    MURPHY, Noel Ferris
    152 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Diretor
    152 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern IrelandBritish99726990001
    HORNER, Robin George
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    Secretário
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    British145344800001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Secretário
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    British143588500001
    PHILSEC LIMITED
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    Secretário nomeado
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    900006520001
    ARMSTRONG, Adam James Moore
    35 Warren Road
    BT21 0PD Donaghadee
    County Down
    Diretor
    35 Warren Road
    BT21 0PD Donaghadee
    County Down
    United KingdomBritish184077380001
    BROWN, Michael James
    c/o Diane Smith
    Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    The Square Shopping Centre
    Cheshire
    England
    Diretor
    c/o Diane Smith
    Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    The Square Shopping Centre
    Cheshire
    England
    Northern IrelandBritish174874620001
    HORNER, Robin George
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    Diretor
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    United KingdomBritish145344800001
    KERSHAW, David Francis
    3 Houghton Close
    CW9 8NW Northwich
    Cheshire
    Diretor
    3 Houghton Close
    CW9 8NW Northwich
    Cheshire
    UkBritish85601560002
    RUSH, William
    140 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern Ireland
    Diretor
    140 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish99727010001
    SILK, Graham Hampson
    Old Well Cottage Broome Clent
    DY9 0EZ Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    Old Well Cottage Broome Clent
    DY9 0EZ Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish3954850001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Diretor
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    EnglandBritish143588500001
    MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    Diretor nomeado
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    900006510001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    31/03/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 23/12/2013
    Entregue em 04/01/2014
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Pessoas com direito
    • National Asset Loan Management Limited
    Transações
    • 04/01/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/06/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge over bank accounts
    Criado em 15/03/2013
    Entregue em 20/03/2013
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The account having account number 90530506 by way of fixed and floating charge all rights benefits and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account see image for full details.
    Pessoas com direito
    • National Asset Loan Management Limited
    Transações
    • 20/03/2013Registro de uma garantia (MG01)
    • 05/06/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of assignment over deferred consideration
    Criado em 01/03/2010
    Entregue em 13/03/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from mar properties limited and mar (argyle) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of a first floating charge all the rights, title and interest referred to and insofar as such charges or any parts or the parts of the same are ineffective as specific or fixed charges see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 13/03/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 05/06/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over shares
    Criado em 05/07/2004
    Entregue em 15/07/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The charged portfolio being all the shares in the share capital of blackpool airport business park limited and the related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transações
    • 15/07/2004Registro de uma garantia (395)
    • 05/06/2015Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0