HCCAH LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHCCAH LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05096889
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HCCAH LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica HCCAH LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HCCAH LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED01/06/200401/06/2004
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED06/04/200406/04/2004

    Quais são as últimas contas de HCCAH LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para HCCAH LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para HCCAH LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Nomeação de Mr James Alexander Burrell como diretor em 10/11/2014

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 31/12/2013

    1 páginasAA

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Registo da garantia 050968890008, criada em 12/06/2014

    91 páginasMR01

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    1 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 06/04/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/04/2014

    Estado do capital em 07/04/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomeação de Mrs Geraldine Josephine Gallagher como diretor em 31/01/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Matthew Edward Bennison como diretor em 31/01/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Matthew Edward Bennison como secretário em 31/01/2014

    1 páginasTM02

    Contas preparadas até 31/12/2012

    1 páginasAA

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Resoluções

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 06/04/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    legacy

    18 páginasMG01

    Contas preparadas até 31/12/2011

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/04/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    legacy

    14 páginasMG01

    Contas preparadas até 31/12/2010

    1 páginasAA

    Nomeação de Mr Matthew Edward Bennison como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Matthew Edward Bennison como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Timothy Doubleday como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de HCCAH LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Diretor
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secretário
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Secretário
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Secretário nomeado
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Diretor
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Diretor
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    Diretor
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    Diretor
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    Diretor
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    Diretor
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    HCCAH LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 12/06/2014
    Entregue em 18/06/2014
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transações
    • 18/06/2014Registro de uma garantia (MR01)
    English law deed of accession
    Criado em 27/02/2013
    Entregue em 01/03/2013
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transações
    • 01/03/2013Registro de uma garantia (MG01)
    • 27/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 01/12/2011
    Entregue em 10/12/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/12/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of accession
    Criado em 18/06/2007
    Entregue em 22/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 22/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 03/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 31/03/2006
    Entregue em 06/04/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    Transações
    • 06/04/2006Registro de uma garantia (395)
    • 16/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    Criado em 24/01/2005
    Entregue em 02/02/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transações
    • 02/02/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 18/12/2003
    Adquirido em 24/01/2005
    Entregue em 27/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    Breve descrição
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transações
    • 27/01/2005Registro de uma aquisição (400)
    • 04/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 14/01/2000
    Adquirido em 24/01/2005
    Entregue em 03/02/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    Pessoas com direito
    • The Secretary of State for Defence
    Transações
    • 03/02/2005Registro de uma aquisição (400)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0