CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 05111485 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
- Atividades hospitalares (86101) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Berkshire England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
SHEPTON MALLET TREATMENT CENTRE LIMITED | 19/07/2004 | 19/07/2004 |
SHEPTON MALLETT TREATMENT CENTRE LIMITED | 29/04/2004 | 29/04/2004 |
EVER 2349 LIMITED | 26/04/2004 | 26/04/2004 |
Quais são as últimas contas de CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/09/2019 |
Quais são as últimas submissões para CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Satisfação total da garantia 051114850005 | 1 páginas | MR04 | ||
Nomeação de Mr Lee Stafford Gage como secretário em 14/04/2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Término da nomeação de Jonathan David Calow como secretário em 14/04/2021 | 1 páginas | TM02 | ||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Declaração de confirmação apresentada em 12/04/2021 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||
Alteração dos detalhes de Care Uk (Uksh) Limited como pessoa com controlo significativo em 01/10/2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Alteração dos detalhes de Care Uk (Uksh) Limited como pessoa com controlo significativo em 08/10/2019 | 2 páginas | PSC05 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England para Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW em 05/08/2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Alteração dos detalhes de Care Uk (Uksh) Limited como pessoa com controlo significativo em 08/10/2019 | 2 páginas | PSC05 | ||
Contas anuais preparadas até 30/09/2019 | 30 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2020 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr David George Stickland como diretor em 25/11/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Andrew James Mackenzie Prosser como diretor em 25/11/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Michael Robert Parish como diretor em 31/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Philip James Whitecross como diretor em 31/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB para Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW em 06/11/2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Contas anuais preparadas até 30/09/2018 | 31 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas anuais preparadas até 30/09/2017 | 26 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas anuais preparadas até 30/09/2016 | 30 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 23/04/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Quem são os diretores de CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGE, Lee Stafford | Secretário | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 282066890001 | |||||||
EASTON, James William | Diretor | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | Company Director | 118320980001 | ||||
STICKLAND, David George | Diretor | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | Company Director | 130704670001 | ||||
CALNAN, Fiona Maria | Secretário | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | Irish | Accountant | 57973740001 | |||||
CALOW, Jonathan David | Secretário | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 176329710001 | |||||||
HORWITZ, Belle | Secretário | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | Consultant | 82932070001 | |||||
KITTOE, Stephen Maurice | Secretário | Southbourne Road BN22 8RE Eastbourne Lavender House, 255 East Sussex | British | 692590012 | ||||||
O'MURCHU, Lorcan | Secretário | 31 Sea Way PO22 7RZ Middleton On Sea The Little House West Sussex | Irish | Finance Director | 139252620001 | |||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secretário | Central Square South Orchard Street NE1 3XX Newcastle Upon Tyne | 60471940007 | |||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secretário nomeado | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
ABUMRAD, Naji, Dr | Diretor | 933 Travelers Ct Nashville Tennessee,Tn 37220 Usa | American | Businessman Company Director | 99950770002 | |||||
BERGER, Laurence | Diretor | 430 E 63rd Street Apt 9e New York New York 10021 Usa | American | Healthcare Admin | 118067530001 | |||||
CALNAN, Fiona Maria | Diretor | 47 Mallard Place Strawberry Vale TW1 4SW Twickenham Middlesex | England | Irish | Accountant | 57973740001 | ||||
HORWITZ, Belle | Diretor | 6 West 77 Street New York New York 10024 United States | American | Consultant | 82932070001 | |||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Diretor | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | Company Director | 33223550003 | ||||
ISSACS, Timothy Keith | Diretor | 4 Raeburn Close NW11 6UE London | British | Investment Manager | 101555530001 | |||||
KITTOE, Nicholas Benedict Montagu | Diretor | Flat 1 355 Clapham Road SW9 9BT London | United Kingdom | British | Businessman | 1852680004 | ||||
KLEIN, Arthur, Dr | Diretor | 515 E. 79 St. Apt. 12a New York New York 10021 Usa | American | Doctor/Health Administrator | 106464770001 | |||||
MORRISON, David John | Diretor | Albert Bridge Road SW11 4PX London 21 | British | Investment Manager | 29500910001 | |||||
O'MURCHU, Lorcan | Diretor | 31 Sea Way PO22 7RZ Middleton On Sea The Little House West Sussex | United Kingdom | Irish | Finance Director | 139252620001 | ||||
PARISH, Michael Robert | Diretor | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | Company Director | 78828750003 | ||||
PROSSER, Andrew James Mackenzie | Diretor | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | Chartered Accountant | 151240810001 | ||||
ROBINSKI, Katarzyna Maria | Diretor | 46 Sutherland Place W2 5BY London | United Kingdom | British | Director | 141565370001 | ||||
WEINER, Jonathan | Diretor | 269 Haviland Road Stamford Connecticut Ct 06903 United States | United Kingdom | American | Business Manager | 82931980001 | ||||
WHITECROSS, Philip James | Diretor | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | Company Director | 193730760001 | ||||
WHITESIDE, Paul Andrew James | Diretor | 10 Barnsdale LE16 8SG Great Easton Leicestershire | England | British | Managing Director | 100247150001 | ||||
EVERDIRECTOR LIMITED | Diretor nomeado | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice Plus Group Uksh Limited | 06/04/2016 | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
CARE UK (SHEPTON MALLET) LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 26/09/2014 Entregue em 01/10/2014 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Security assignment | Criado em 11/08/2006 Entregue em 19/08/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All its right title interest and benefit in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental account charge | Criado em 18/10/2005 Entregue em 21/10/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The chargor charges the supplemental security assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Security agreement | Criado em 19/08/2004 Entregue em 01/09/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All estates or interests in any f/h or l/h property, all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery on that property and the benefit of any covenants for title, all plant and machinery, all rights of any amount standing to the credit of the rent proceeds account and all rights in respect of the project documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Account charge | Criado em 19/08/2004 Entregue em 01/09/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The security assets (being all monies from time to time standing to the credit of the security accounts). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0