DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED

DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05450724
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    • Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias

    Onde fica DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Challenge House International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INHOCO 4092 LIMITED12/05/200512/05/2005

    Quais são as últimas contas de DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/09/2026
    Próximas contas vencem em30/06/2027
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2025

    Qual é o status da última declaração de confirmação para DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até01/05/2026
    Próxima declaração de confirmação vence15/05/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até01/05/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2025

    20 páginasAA

    Nomeação de Mr Christopher Edwin Walker como diretor em 10/10/2025

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr James Michael Weaver como diretor em 04/04/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Eugene Martin Prinsloo como diretor em 04/04/2025

    1 páginasTM01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2024

    20 páginasAA

    Término da nomeação de Georgina Claire Brown como secretário em 07/10/2024

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Andrew Philip Holland como secretário em 07/10/2024

    2 páginasAP03

    Nomeação de Mr Gareth Wyn Jones como diretor em 03/10/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Matthew Graham Hartland como diretor em 30/08/2024

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2023

    20 páginasAA

    Nomeação de Mr Eugene Martin Prinsloo como diretor em 08/12/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mark William Grinonneau como diretor em 20/11/2023

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2022

    20 páginasAA

    Término da nomeação de Daniel Marinus Maria Vermeer como diretor em 27/09/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Richard Darch como diretor em 21/06/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 30/09/2021

    19 páginasAA

    Nomeação de Mrs Charlotte Sophie Ellen Douglass como diretor em 29/07/2021

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Georgina Claire Brown como secretário em 21/07/2021

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Andrew Philip Holland como secretário em 21/07/2021

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Pembroke House Banbury Business Park Adderbury Banbury Oxon OX17 3NS England para Challenge House International Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8UQ

    1 páginasAD02

    Quem são os diretores de DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HOLLAND, Andrew Philip
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Secretário
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    328122420001
    ANDREWS, Paul Simon
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    Diretor
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3 More London Riverside
    England
    EnglandBritish119057120007
    DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Diretor
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish245967540001
    JONES, Gareth Wyn
    St Peter's Square
    WV1 1SH Wolverhampton
    Civic Centre
    United Kingdom
    Diretor
    St Peter's Square
    WV1 1SH Wolverhampton
    Civic Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish327848240001
    WALKER, Christopher Edwin
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Diretor
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish267835110001
    WEAVER, James Michael
    Portland Street
    M1 3LD Manchester
    53
    England
    Diretor
    Portland Street
    M1 3LD Manchester
    53
    England
    EnglandBritish334406660001
    BEVAN, Daniel Peter
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Secretário
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    253172340001
    BROWN, Georgina Claire
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Secretário
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    285473470001
    DAVIES, Roger Andrew
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    United Kingdom
    Secretário
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    United Kingdom
    162572840001
    HOLLAND, Andrew Philip
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Secretário
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    280349630001
    PHILLIPS, Judith Carlyon
    Banbury Business Park
    Aynho Road Adderbury
    OX17 3NS Banbury
    Pembroke House
    Oxfordshire
    England
    Secretário
    Banbury Business Park
    Aynho Road Adderbury
    OX17 3NS Banbury
    Pembroke House
    Oxfordshire
    England
    179421630001
    POLLARD, Carolyn Jane
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Secretário
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    202465760001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BARNES, Simon John
    Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    One
    England
    Diretor
    Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    One
    England
    EnglandBritish181364860001
    BOOTH, Ian
    42 Park Road
    RH8 0AW Oxted
    Surrey
    Diretor
    42 Park Road
    RH8 0AW Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish118447660001
    CARROLL, Paul Bryan
    c/o Assura Group
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brewhouse
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Assura Group
    Greenalls Avenue
    WA4 6HL Warrington
    The Brewhouse
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish85123780001
    COOKE, Mark
    Dorricot
    Church Lane Middleton
    B78 2AW Tamworth
    Staffordshire
    Diretor
    Dorricot
    Church Lane Middleton
    B78 2AW Tamworth
    Staffordshire
    British109480480001
    DARCH, Richard
    Upper Borough Walls
    BA1 1RG Bath
    Archus Limited, Northgate House
    England
    Diretor
    Upper Borough Walls
    BA1 1RG Bath
    Archus Limited, Northgate House
    England
    EnglandBritish178693100001
    DARCH, Richard
    c/o Ashley House Plc
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    Diretor
    c/o Ashley House Plc
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish178693100001
    DARCH, Richard
    Beaufort House
    London Road
    BA1 6PZ Bath
    Avon
    Diretor
    Beaufort House
    London Road
    BA1 6PZ Bath
    Avon
    EnglandBritish88696540001
    DAY, Mark
    Piccadilly
    M1 2HY Manchester
    111
    United Kingdom
    Diretor
    Piccadilly
    M1 2HY Manchester
    111
    United Kingdom
    EnglandBritish157242280001
    DYER, Matthew Stephen
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    Diretor
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    EnglandBritish127210860001
    FARLEY, George Peter
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish123834510001
    GAFFNEY, Kevin Joseph Leo
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    Diretor
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    United KingdomBritish155605810001
    GRINONNEAU, Mark William
    London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    Diretor
    London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    United KingdomBritish323896400001
    GRINONNEAU, Mark William
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    Diretor
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish323896400001
    HARRISON, Andrew William
    15 Wolverton Road
    Radnal
    B45 8RL Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    15 Wolverton Road
    Radnal
    B45 8RL Birmingham
    West Midlands
    British108454600001
    HARTLAND, Matthew Graham
    Venture Way
    DY5 1RU Brierley Hill
    Brierley Hill Health And Social Care Centre
    England
    Diretor
    Venture Way
    DY5 1RU Brierley Hill
    Brierley Hill Health And Social Care Centre
    England
    EnglandBritish190205840002
    HARTLAND, Matthew Graham
    Floor St Johns House
    Union Street
    DY2 8PP Dudley
    4th
    West Midlands
    England
    Diretor
    Floor St Johns House
    Union Street
    DY2 8PP Dudley
    4th
    West Midlands
    England
    EnglandBritish136310470001
    HARTLAND, Matthew Graham
    c/o C/O Mr R A Davies
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    England
    Diretor
    c/o C/O Mr R A Davies
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish136310470001
    HARTSHORNE, David John Morice
    c/o Ashley House
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    Diretor
    c/o Ashley House
    Cliveden Office Village, Lancaster Road
    Cressex Business Park
    HP12 3YZ High Wycombe
    6
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish87382740001
    HOLMES, Jonathan
    c/o C/O Mr R A Davies
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    England
    Diretor
    c/o C/O Mr R A Davies
    Farncombe
    WR12 7LJ Broadway
    Farncombe House
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish107261280002
    JONES, David Richard
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    Diretor
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    EnglandBritish162465130002
    KENNEDY, Angus John, Dr
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    Diretor
    Floor West Wing Brierley Hill
    Health & Social Care Centre
    DY5 1RU Venture Way
    3rd
    Brierley Hill, West Midlands
    EnglandBritish81502080001
    MORRIS, William Edward
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    Diretor
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish289326600001

    Quem são as pessoas com controle significativo de DUDLEY INFRACARE LIFT LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    12/05/2017
    International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Challenge House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro5450735
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 50% mas não mais de 75% das ações da empresa.
    London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    12/05/2017
    London Road
    SE1 6LH London
    Skipton House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro04220587
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0