HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED

HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05464862
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Marble Arch House
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LXB HOLDINGS LIMITED21/06/200521/06/2005
    CONTINENTAL SHELF 341 LIMITED26/05/200526/05/2005

    Quais são as últimas contas de HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2022

    Quais são as últimas submissões para HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022

    7 páginasAA

    Alteração dos detalhes de Hammerson Uk Properties Limited como pessoa com controlo significativo em 16/01/2023

    2 páginasPSC05

    Nomeação de Mr Richard Geoffrey Shaw como diretor em 31/05/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Dominic Martin Etienne Page como diretor em 31/05/2023

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 26/05/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Paul Justin Denby como diretor em 28/04/2023

    1 páginasTM01

    Detalhes do secretário alterados para Hammerson Company Secretarial Limited em 16/01/2023

    1 páginasCH04

    Endereço do domicílio registado alterado de Kings Place 90 York Way London N1 9GE para Marble Arch House 66 Seymour Street London W1H 5BX em 16/01/2023

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021

    7 páginasAA

    Alteração dos detalhes de Hammerson Uk Properties Limited como pessoa com controlo significativo em 12/05/2022

    2 páginasPSC05

    Declaração de confirmação apresentada em 26/05/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Hammerson Uk Properties Plc como pessoa com controlo significativo em 12/05/2022

    2 páginasPSC05

    Nomeação de Mr Dominic Page como diretor em 15/02/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Abigail Dunning como diretor em 15/02/2022

    1 páginasTM01

    Nomeação de Miss Abigail Dunning como diretor em 11/11/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mark Richard Bourgeois como diretor em 11/11/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr. Paul Justin Denby como diretor em 11/11/2021

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Charles Travis em 11/10/2021

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    4 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 26/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Thomas Cochrane como diretor em 19/05/2021

    1 páginasTM01

    Segunda apresentação para a nomeação de Thomas Cochrane como administrador

    5 páginasRP04AP01

    Quem são os diretores de HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HAMMERSON COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Secretário
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro7784823
    163656260001
    SHAW, Richard Geoffrey
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Diretor
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    EnglandBritish309924610001
    TRAVIS, Simon Charles
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Diretor
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    EnglandBritish139105930003
    HAYDON, Stuart John
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Secretário
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    British3175210001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    69 Priests Lane
    CM15 8HG Shenfield
    Essex
    Secretário
    69 Priests Lane
    CM15 8HG Shenfield
    Essex
    British142108250001
    MACNEILL, Stewart
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    Secretário
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    British105836130001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secretário nomeado
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritish126970360001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Diretor
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    Diretor
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish144036070001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Diretor
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    EnglandBritish134630050001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Diretor
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    EnglandBritish134630050001
    BOURGEOIS, Mark Richard
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Diretor
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    EnglandBritish60776880004
    BURNETT, Neil Scott
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    Diretor
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    British93937250001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish71820020003
    COCHRANE, Thomas
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Diretor
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United KingdomBritish273384660001
    COLE, Peter William Beaumont
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Diretor
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    EnglandBritish51145990001
    DENBY, Paul Justin
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Diretor
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    EnglandBritish167898970002
    DUNNING, Abigail Jane
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    Diretor
    90 York Way
    N1 9GE London
    Kings Place
    United KingdomBritish293555050001
    EMERY, Jonathan Michael
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    Diretor
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    British78621400001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Diretor
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Diretor
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    EnglandBritish56627250001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    69 Priests Lane
    CM15 8HG Shenfield
    Essex
    Diretor
    69 Priests Lane
    CM15 8HG Shenfield
    Essex
    United KingdomBritish142108250001
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Diretor
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    HUTCHINGS, Lawrence Francis
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Diretor
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    EnglandBritish134630060001
    JEPSON, Martin Clive
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Diretor
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    United KingdomBritish92627900001
    MACNEILL, Stewart
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    Diretor
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    British105836130001
    MACNEILL, Stewart
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    Diretor
    19 Egmont Avenue
    KT6 7AU Surbiton
    Surrey
    British105836130001
    MCCARTHY, Jonathan
    Flat 4 The Builders Arms
    140 St Pauls Road
    N1 2AP London
    Diretor
    Flat 4 The Builders Arms
    140 St Pauls Road
    N1 2AP London
    British106842740001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Diretor
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    PAGE, Dominic Martin Etienne
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Diretor
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    United KingdomBritish293002100001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Diretor
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    THOMSON, Andrew James Gray
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    Diretor
    Grosvenor Street
    W1K 4BJ London
    10
    England
    EnglandBritish97267360001
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish59971310002
    WESTON, Stephen Robert
    31 Highview
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    Diretor
    31 Highview
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish59888710001

    Quem são as pessoas com controle significativo de HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    06/04/2016
    66 Seymour Street
    W1H 5BX London
    Marble Arch House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro298351
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    HAMMERSON RETAIL PARKS HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage over securities
    Criado em 14/07/2006
    Entregue em 18/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities and the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transações
    • 18/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 12/01/2006
    Entregue em 16/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities and the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares and the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 17/11/2005
    Entregue em 21/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities and the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares and dividends as defined in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 21/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 10/11/2005
    Entregue em 15/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed charge the shares and the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 15/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 14/09/2005
    Entregue em 19/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and the charging group entities to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of fixed charge (a) the shares (b) the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transações
    • 19/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 10/08/2005
    Entregue em 15/08/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities and the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed charge the shares being one share in the company named lxb properties (luton) limited, and the dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transações
    • 15/08/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 21/07/2005
    Entregue em 25/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed charge the shares and the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage over securities
    Criado em 29/06/2005
    Entregue em 06/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging group entities and the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of fixed charge the shares as defined in the schedule to the form 395 and the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 06/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0