LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05586358
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    • Processamento e conservação de peixe, crustáceos e moluscos (10200) / Indústrias transformadoras

    Onde fica LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FINDUS GROUP LIMITED28/05/200928/05/2009
    FOODVEST LIMITED08/11/200508/11/2005
    BROOMCO (3920) LIMITED07/10/200507/10/2005

    Quais são as últimas contas de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2018

    Quais são as últimas submissões para LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Segunda apresentação de um estado de capital após uma atribuição de ações em 03/07/2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    18 páginasRP04SH01

    Nomeação de Mr John Philip Madden como diretor em 08/11/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de William John Showalter como diretor em 11/11/2019

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW para Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ em 08/11/2019

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    41 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resoluções

    Conflicts of interest 03/07/2019
    RES13
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2018

    6 páginasAA

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 03/07/2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    11 páginasSH01
    Anotações
    DataAnotação
    27/11/2019Clarification A second filed SH01 was registered on 27/11/2019.

    Satisfação total da garantia 055863580006

    4 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017

    7 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd em 02/01/2017

    1 páginasCH04

    Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2016

    16 páginasAA

    Memorando e estatutos

    38 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Término da nomeação de Karen Jeanette Noakes como diretor em 01/02/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2016 com atualizações

    13 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2015

    16 páginasAA

    Nomeação de Karen Jeanette Noakes como diretor em 29/02/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Guy Nicholas Anthony Faller como diretor em 29/02/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Christopher Frank Parker como diretor em 31/01/2016

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secretário nomeado
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2249348
    900013350001
    MADDEN, John Philip
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Diretor
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritish264245380001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Secretário
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    British84487230001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Diretor
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CAMPBELL, Christopher
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    Diretor
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    American109921890001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Diretor
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Diretor
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish108529830002
    FITZPATRICK, Seamus Philip
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    Diretor
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    United KingdomIrish65991000003
    FORBES, Hamish Drummond
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Diretor
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Diretor
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Diretor
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Danish78882450002
    JOHANSSON, Roger
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Diretor
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Swedish113571210001
    KARLSSON, Cecilia
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Diretor
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Swedish113571120001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Diretor
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LITTLE, Malcolm John
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    Diretor
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish44199400002
    MILNER, David Richard
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    Diretor
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    United KingdomBritish150546560001
    NOAKES, Karen Jeanette
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Diretor
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish134379900001
    OLSSON, Jorgen
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Diretor
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Swedish113571020001
    PARKER, Christopher Frank
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Diretor
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish66681550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Diretor
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    SHOWALTER, William John
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Diretor
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandAmerican178622380001
    SHURE, Randl Louis
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    Diretor
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    American94192640001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Diretor
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Quem são as pessoas com controle significativo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06/04/2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalLaw Of England And Wales
    Local de registroCompanies House
    Número de registro06025321
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 02/11/2015
    Entregue em 09/11/2015
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transações
    • 09/11/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 13/05/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 19/07/2013
    Entregue em 25/07/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Societe Generale, London Branch
    Transações
    • 25/07/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 23/10/2008
    Entregue em 01/11/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transações
    • 01/11/2008Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 21/03/2007
    Entregue em 31/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale the Security Agent
    Transações
    • 31/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 23/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 16/03/2006
    Entregue em 25/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transações
    • 25/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 23/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 12/12/2005
    Entregue em 17/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transações
    • 17/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 26/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0