LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 05586358 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
- Processamento e conservação de peixe, crustáceos e moluscos (10200) / Indústrias transformadoras
Onde fica LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby North East Lincolnshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| FINDUS GROUP LIMITED | 28/05/2009 | 28/05/2009 |
| FOODVEST LIMITED | 08/11/2005 | 08/11/2005 |
| BROOMCO (3920) LIMITED | 07/10/2005 | 07/10/2005 |
Quais são as últimas contas de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2018 |
Quais são as últimas submissões para LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Segunda apresentação de um estado de capital após uma atribuição de ações em 03/07/2019
| 18 páginas | RP04SH01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr John Philip Madden como diretor em 08/11/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de William John Showalter como diretor em 11/11/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW para Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ em 08/11/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 41 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 03/07/2019
| 11 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Satisfação total da garantia 055863580006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd em 02/01/2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/09/2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Memorando e estatutos | 38 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 p áginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Karen Jeanette Noakes como diretor em 01/02/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/10/2016 com atualizações | 13 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/09/2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Nomeação de Karen Jeanette Noakes como diretor em 29/02/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Guy Nicholas Anthony Faller como diretor em 29/02/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Christopher Frank Parker como diretor em 31/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Quem são os diretores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| MADDEN, John Philip | Diretor | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | British | 264245380001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Secretário | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | British | 84487230001 | ||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Diretor | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| CAMPBELL, Christopher | Diretor | 74 Coleherne Court Little Boltons SW5 0EF London | American | 109921890001 | ||||||||||
| CANE, James Robert | Diretor | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| FALLER, Guy Nicholas Anthony | Diretor | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 108529830002 | |||||||||
| FITZPATRICK, Seamus Philip | Diretor | Flat 1 1 Onslow Gardens SW7 3LX London | United Kingdom | Irish | 65991000003 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Diretor | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | England | British | 66295550001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Diretor | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | 58713750002 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Diretor | Strandvejen 399a Klampenborg 2930 Denmark | Danish | 78882450002 | ||||||||||
| JOHANSSON, Roger | Diretor | Kompassgatan 36 FOREIGN Malmo 211 17 Sweden | Swedish | 113571210001 | ||||||||||
| KARLSSON, Cecilia | Diretor | Vassarogatan 11 Rydebaeck 25733 Sweden | Swedish | 113571120001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Diretor | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LITTLE, Malcolm John | Diretor | Leylandii House 3 Shipton Road YO30 5RE York North Yorkshire | United Kingdom | British | 44199400002 | |||||||||
| MILNER, David Richard | Diretor | Park House Holkham NR23 1RN Norfolk | United Kingdom | British | 150546560001 | |||||||||
| NOAKES, Karen Jeanette | Diretor | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | England | British | 134379900001 | |||||||||
| OLSSON, Jorgen | Diretor | Grontevaegen 3 Helsingborg 25285 Sweden | Swedish | 113571020001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher Frank | Diretor | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 66681550001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Diretor | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| SHOWALTER, William John | Diretor | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | American | 178622380001 | |||||||||
| SHURE, Randl Louis | Diretor | 2045 Dogwood Lane IRISH Charlottesville Virginia 22901 Usa | American | 94192640001 | ||||||||||
| WARD, Peter Selwyn | Diretor | 155 Eastgate LN11 8DB Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 33803400001 | |||||||||
| DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED | Diretor | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610002 | |||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Diretor | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Ukco 3 Limited | 06/04/2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 02/11/2015 Entregue em 09/11/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 19/07/2013 Entregue em 25/07/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 23/10/2008 Entregue em 01/11/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 21/03/2007 Entregue em 31/03/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 16/03/2006 Entregue em 25/03/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 12/12/2005 Entregue em 17/12/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0