CASTLE COVER LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCASTLE COVER LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05698370
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CASTLE COVER LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica CASTLE COVER LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Ageas House Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CASTLE COVER LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NUMBERONECORP LIMITED06/02/200606/02/2006

    Quais são as últimas contas de CASTLE COVER LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para CASTLE COVER LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/02/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/02/2016

    Estado do capital em 10/02/2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomeação de Mr Anthony Edward Middle como diretor em 01/10/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Peter James Corfield como diretor em 01/10/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/02/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/02/2015

    Estado do capital em 10/02/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Diversos

    Section 519 ca 2006
    2 páginasMISC

    Diversos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    17 páginasAA

    Declaração anual preparada até 06/02/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/02/2014

    Estado do capital em 14/02/2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Ageas House Tollgate Eastleigh Hampshire SO53 3YA United Kingdom* em 30/09/2013

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Andrew Watson como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Peter Friend como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Fernley Dyson como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de James Collins como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Mark Cliff como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Robert Bright como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    18 páginasAA

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Estado do capital em 25/04/2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    Quem são os diretores de CASTLE COVER LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SMITH, Rosemary
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretário
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    159166410001
    LEMANS, Nicholas James
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant114355520003
    MIDDLE, Anthony Edward
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    Diretor
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector129283070001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Secretário
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    LEPPINGTON, Peter Edward
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    Secretário
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    English109752090001
    PREBBLE, Ashley Brett
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Secretário
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    BritishSolicitor94781040001
    PREBBLE, Ashley Brett
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Secretário
    7a Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    BritishSolicitor94781040001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Secretário nomeado
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BOYES, Andrew Charles
    62 Barn Piece
    Chandlers Ford
    SO53 4HR Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    62 Barn Piece
    Chandlers Ford
    SO53 4HR Eastleigh
    Hampshire
    BritishIt Director98554230001
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40471660002
    BRIGHT, Robert Stewart
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector145809660001
    CARTER, Patrick Robert, Lord
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    Diretor
    60 Hamilton Park West
    N5 1AB London
    United KingdomBritishCompany Director6338850001
    CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice
    Heronspool
    Accommodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Diretor
    Heronspool
    Accommodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    BritishDirector5828350003
    CLIFF, Mark
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector197694550001
    COLE, Andrew John
    39 High Street
    EX10 9SH Sidford
    Greenacres
    Devon
    Diretor
    39 High Street
    EX10 9SH Sidford
    Greenacres
    Devon
    BritishMarketing Director137614980001
    COLLINS, James William
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector160150700001
    CONNOR, Janet
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director77312440003
    CORFIELD, Peter James
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hampshire Corporate Park
    Templars Way
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector163452900001
    DYSON, Fernley Keith
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector127180610001
    FRIEND, Peter Richard Henry
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector14914420007
    HARVEY, Julian Robert Mark
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector161523620001
    HOWE, Sarah Anne
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector147052720002
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Diretor
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritishInsurance Broker33901640008
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Diretor
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritishInsurance Broker33901640008
    LEPPINGTON, Peter Edward
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    Diretor
    17 Chiswell Road
    BH17 9FB Poole
    Dorset
    EnglandEnglishCompany Director109752090001
    MARCHINGTON, Andrew Philip
    Hillcrest
    19 Brudenell Avenue
    BH13 7NW Poole
    Dorset
    Diretor
    Hillcrest
    19 Brudenell Avenue
    BH13 7NW Poole
    Dorset
    EnglandBritishManaging Director114691900001
    MORLEY HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Diretor
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    BritishDirector80334700004
    MORLEY-HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Diretor
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    AntiguaBritishDirector156236170001
    MURRAY, Alastair Neil
    Viewfield Road
    SW18 5JE Wandsworth
    22
    London
    Diretor
    Viewfield Road
    SW18 5JE Wandsworth
    22
    London
    United KingdomBritishChartered Accountant124855970002
    READER, James Owen
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    Diretor
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    BritishTrainee Solicitor112551820001
    READER, James Owen
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    Diretor
    11 Killarney Road
    Wandsworth
    SW18 2DU London
    BritishTrainee Solicitor112551820001
    SMITH, Barry Duncan
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector47378680003
    SMYTH, Timothy John
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    Diretor
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishInsurance Broker77794000002
    WATSON, Andrew Stuart
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Tollgate
    SO53 3YA Eastleigh
    Ageas House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector124578530001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    Diretor nomeado
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    CASTLE COVER LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 28/09/2012
    Entregue em 05/10/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 05/10/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 04/05/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 01/05/2007
    Entregue em 19/05/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Axa Insurance UK PLC
    Transações
    • 19/05/2007Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 17/05/2006
    Entregue em 27/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 27/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0