INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED

INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 05797796
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    • Administração de imóveis por conta de terceiros (68320) / Atividades imobiliárias
    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    3rd Floor 3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    England
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ALNERY NO. 2596 LIMITED27/04/200627/04/2006

    Quais são as últimas contas de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2026
    Próximas contas vencem em30/09/2027
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2025

    Qual é o status da última declaração de confirmação para INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até01/05/2026
    Próxima declaração de confirmação vence15/05/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até01/05/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas anuais preparadas até 31/12/2025

    32 páginasAA

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 páginasRP01AP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr John Gerard Connelly em 07/10/2025

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr James Peter Marsh como diretor em 30/04/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Daniel Colin Ward como diretor em 30/04/2025

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2024

    32 páginasAA

    Nomeação de Mr John Gerard Connelly como diretor em 12/09/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Conor Mcmanus como diretor em 12/09/2024

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Barry Paul Millsom em 21/12/2023

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2023

    32 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Conor Mcmanus como diretor em 02/02/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Barry Paul Millsom como diretor em 21/12/2023

    3 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    03/04/2026Replaced Replacement AP01 was registered 03/04/2026 as the original contained an error

    Nomeação de Mr Michael James Williams como diretor em 21/12/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neeti Mukundrai Anand como diretor em 31/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Alexander Victor Thorne como diretor em 21/12/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Laurence David Carter como diretor em 21/12/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr William John Payne como diretor em 27/11/2023

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2022

    32 páginasAA

    Nomeação de Albany Secretariat Limited como secretário em 17/04/2023

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Paul James Hatcher como secretário em 17/04/2023

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2021

    32 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Jonathan Laurence David Carter em 03/10/2022

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ALBANY SECRETARIAT LIMITED
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Secretário
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro14325732
    303585870001
    CONNELLY, John Gerard
    c/o Cvc
    80 Strand
    WC2R 0RE London
    4th Floor
    England
    Diretor
    c/o Cvc
    80 Strand
    WC2R 0RE London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish323811250001
    MARSH, James Peter
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    Diretor
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    EnglandBritish278818400039
    MILLSOM, Barry Paul
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Diretor
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish346391250001
    PAYNE, William John
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    England
    Diretor
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    England
    United KingdomBritish215789590001
    PEARMAN, Katherine Anne Louise
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Diretor
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritish226963920001
    SAVJANI, Kalpesh
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    United Kingdom
    Diretor
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish185483460002
    WILLIAMS, Michael James
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    Diretor
    c/o Albany Spc Services Limited
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish263619910002
    HATCHER, Paul James
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    Secretário
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    294320280001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretário nomeado
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Secretário
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro5615519
    109588620001
    ANAND, Neeti Mukundrai
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    Diretor
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    EnglandBritish250186840001
    BLANCHARD, David Graham
    c/o C/O Amber Infrastructure Limited
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    Diretor
    c/o C/O Amber Infrastructure Limited
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    EnglandBritish148329480001
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Diretor
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    British42234330002
    BRAND, Susan Heather Charlotte
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Maidenhead
    Costain House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Maidenhead
    Costain House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish179233660001
    CARTER, Jonathan Laurence David
    One Bartholomew Close
    EC1A 7BL London
    Level 7
    England
    Diretor
    One Bartholomew Close
    EC1A 7BL London
    Level 7
    England
    United KingdomBritish300727920001
    CASHIN, Benjamin Matthew
    Dryden Road
    NE9 5DA Gateshead
    199
    Tyne And Wear
    Diretor
    Dryden Road
    NE9 5DA Gateshead
    199
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish131562890001
    CHANNON, Martin
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Diretor
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritish82663750001
    CONNELLY, John Gerard
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Diretor
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    ScotlandBritish152971000001
    COOPER, Phillip John
    126 Broad Hinton
    RG10 0XH Twyford
    Berkshire
    Diretor
    126 Broad Hinton
    RG10 0XH Twyford
    Berkshire
    United KingdomBritish116775310001
    CORBITT, Morton Bruce
    Longdyke
    Merrow Lane
    GU4 7BD Guildford
    Surrey
    Diretor
    Longdyke
    Merrow Lane
    GU4 7BD Guildford
    Surrey
    EnglandBritish117809710001
    COTTRELL, Keith
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Diretor
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritish88691090005
    DE COURCY ASTON, Helen
    24 Wincham Road
    M33 4PL Sale
    Cheshire
    Diretor
    24 Wincham Road
    M33 4PL Sale
    Cheshire
    British117809530001
    ENGLISH, Nick Stuart
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    Diretor
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    United KingdomBritish162468030001
    FAULKNER, Anthony Robert
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    Infrared Capital Partners
    England
    Diretor
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    Infrared Capital Partners
    England
    United KingdomBritish214155150001
    FAVRE, Sarah Elisabeth Madeleine
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Diretor
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomFrench261338430001
    GHAFOOR, Asif
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Diretor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish277343840001
    GHAFOOR, Asif
    2 Wolsey Road
    N1 4QH Islington
    Diretor
    2 Wolsey Road
    N1 4QH Islington
    United KingdomBritish277343840001
    GRANT, Stewart Chalmers
    Level 4
    2 - 4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    Diretor
    Level 4
    2 - 4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    United Kingdom
    EnglandBritish255209380001
    GRANT, Stewart Chalmers
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    England
    Diretor
    Level 4
    2-4 Idol Lane
    EC3R 5DD London
    Dif Uk
    England
    United KingdomBritish206362380001
    GREGORY, Michael John
    c/o Amber Infrastructure Limited
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    Diretor
    c/o Amber Infrastructure Limited
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    United KingdomBritish114324790003
    GREGORY, Michael John
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    Diretor
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    United KingdomBritish114324790003
    HALL SMITH, James Edward
    Abbey Oak
    Wherwell
    SP11 7HY Andover
    Hampshire
    Diretor
    Abbey Oak
    Wherwell
    SP11 7HY Andover
    Hampshire
    United KingdomBritish86362140001
    HANDFORD, Alistair John
    Rowleys
    Freith
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Rowleys
    Freith
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish58215600004
    LAMSTAES, Pierre Gaetan
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Costain House
    England
    Diretor
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Costain House
    England
    EnglandBritish180143520001

    Quem são as pessoas com controle significativo de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    06/04/2016
    3 - 5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    3rd Floor
    England
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro5797788
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0