EVOLVE ENERGY LTD
Visão geral
| Nome da empresa | EVOLVE ENERGY LTD |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 05831752 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de EVOLVE ENERGY LTD?
- Instalação elétrica (43210) / Construção
Onde fica EVOLVE ENERGY LTD?
| Endereço do escritório registrado | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de EVOLVE ENERGY LTD?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para EVOLVE ENERGY LTD?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomeação de Nathan Sanders como diretor em 03/05/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Peter Bradley como diretor em 12/04/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Aled Robert Humphreys como diretor em 12/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/02/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Brian Dominic Sharma como secretário em 18/09/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Archie Stuart Waddell como secretário em 18/09/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/02/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Brian Dominic Sharma como secretário em 05/07/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Archie Stuart Waddell como secretário em 05/07/2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/02/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de James Mcphillimy como diretor em 31/10/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Brian Dominic Sharma como secretário em 11/05/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Veronica Mary Niven como secretário em 11/05/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2016 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Brinsley Sheridan como diretor em 15/10/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Aled Robert Humphreys como diretor em 12/08/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 21/03/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 21/03/2014 | 16 páginas | RP04 | ||||||||||
Quem são os diretores de EVOLVE ENERGY LTD?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARMA, Brian Dominic | Secretário | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250773850001 | |||||||
| BRADLEY, Peter | Diretor | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Sse Enterprise Energy Solutions Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75211210001 | |||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Diretor | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| SANDERS, Nathan | Diretor | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 150936520002 | |||||
| BUDD, Gerald Lance | Secretário | Manston Road GU4 7YE Guildford 4 Surrey | British | 20717760001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Secretário | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 170751860001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Secretário | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190141550001 | |||||||
| PARKE, Gary | Secretário | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| SCHNEIDER, Tim | Secretário | Citra Barn Frizers Farm Sonning Eye RG4 6TN Reading Berkshire | Canadian | 117731640001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Secretário | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208039170001 | |||||||
| TOPP, Janice Susan | Secretário | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Other | 139112080001 | ||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Secretário | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996520001 | |||||||
| DUPORT SECRETARY LIMITED | Secretário nomeado | 2 Southfield Road BS9 3BH Westbury On Trym The Bristol Office Bristol | 900020060001 | |||||||
| BAETZ, Michael | Diretor | 161 Bay Street, Suite 4540 PO BOX 709 M5J2S1 Toronto Canada Trust Tower Ontario Canada | Canada | Canadian | 166562600001 | |||||
| FRIGHT, Neil Grant | Diretor | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 165864840002 | |||||
| HIGGINS, Vanessa Claire | Diretor | Denchworth OX12 0DX Wantage Denchworth Manor Oxfordshire United Kingdom | England | British | 139427570001 | |||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Diretor | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Diretor | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Diretor | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670003 | |||||
| MCPHILLIMY, James | Diretor | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||
| NIVEN, Veronica Mary | Diretor | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 173743440001 | |||||
| PARKE, Gary | Diretor | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| ROTHERHAM, David Scott | Diretor | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 146140260002 | |||||
| SCHNEIDER, Timothy John | Diretor | Wyatt Close Wargrave RG10 8EB Reading 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150003200001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Diretor | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Diretor | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHLESINGER, Joseph Charles | Diretor | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 139607450001 | |||||
| SOPER, Daniel | Diretor | 20 Grey Road Toronto Ontario M5m 4ez Canada | Canadian | 117597800001 | ||||||
| STEVENSON, Lawrence Napier | Diretor | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 131305220002 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Diretor | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | England | British | 23661940005 | |||||
| DUPORT DIRECTOR LIMITED | Diretor nomeado | 2 Southfield Road Westbury-On-Trym BS9 3BH Bristol | 900020050001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de EVOLVE ENERGY LTD?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Energy Solutions Group Bidco Limited | 06/04/2016 | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
EVOLVE ENERGY LTD possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 02/11/2012 Entregue em 10/11/2012 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 25/07/2012 Entregue em 15/08/2012 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Criado em 21/07/2011 Entregue em 29/07/2011 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 20/06/2008 Entregue em 24/06/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Pledge | Criado em 30/11/2006 Entregue em 14/12/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0