LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 06137133 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
- Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| PTCS 6155A LIMITED | 05/03/2007 | 05/03/2007 |
Quais são as últimas contas de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Morton Fraser Llp St Martins House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN para 1 More London Place London SE1 2AF em 08/01/2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de David Mel Zuydam como diretor em 01/01/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Mel Zuydam como diretor em 11/07/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Katerina Brown como diretor em 04/07/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Scott Leitch Mackenzie como diretor em 30/01/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew William Lee como diretor em 05/12/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Alan Walters como diretor em 05/12/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 14 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mark Alan Walters como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mark Alan Walters como diretor em 14/12/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Nagle como diretor em 14/12/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Andrew William Lee como diretor em 14/12/2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Huw Griffiths como diretor em 14/12/2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Secretário | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Diretor | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretário | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246720001 | |||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secretário | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566850001 | |||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secretário | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Secretário | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| LONG, Jacqueline | Secretário | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213410001 | |||||||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Secretário | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 148856600001 | |||||||||
| BROWN, Katerina | Diretor | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||
| BUXTON, Tony Martyn | Diretor | Oaklands Somerford Road GL7 1FA Cirencester 33 Glos United Kingdom | England | British | 132588550002 | |||||||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Diretor | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 154908310001 | |||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||||||
| HEWSON, John Francis | Diretor | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Diretor | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Diretor | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| HULLEY, Stephen Paul | Diretor | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 58163070002 | ||||||||||
| LEE, Andrew William | Diretor | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Diretor | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Diretor | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||
| NAGLE, Michael | Diretor | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Diretor | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||
| QUINLAN, Rory John | Diretor | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||||||
| ROUND, Richard Calvin | Diretor | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||||||
| WALTERS, Mark Alan | Diretor | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 317548840001 | |||||||||
| ZUYDAM, David Mel | Diretor | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 259635370001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinis Wind Holdings Limited | 06/04/2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 15/12/2017 Entregue em 29/12/2017 | Pendente | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 09/10/2013 Entregue em 11/10/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 19/11/2007 Entregue em 26/11/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0