POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK

POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPOLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social, isenção de uso de 'Limited'
    Número da empresa 06763889
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    • Outras atividades de serviços n.e.c. (96090) / Outras atividades de serviços

    Onde fica POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    Endereço do escritório registrado
    15 Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2026
    Próximas contas vencem em31/12/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2025

    Qual é o status da última declaração de confirmação para POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    Última declaração de confirmação elaborada até02/12/2026
    Próxima declaração de confirmação vence16/12/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até02/12/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Nomeação de Miss Janette Elizabeth Mannell como secretário em 23/02/2026

    2 páginasAP03

    Endereço do domicílio registado alterado de 10 Coldbath Square London EC1R 5HL para 15 Stoneleigh Avenue Brighton BN1 8NP em 12/01/2026

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/12/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2025

    3 páginasAA

    Nomeação de Ms Margaret Fiona Bassendine como diretor em 06/09/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Humphrey Julian Francis Hodgson como diretor em 06/09/2025

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Wendy Jane Morrison como diretor em 06/09/2025

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/12/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Sara Nicole Muller como diretor em 13/02/2024

    1 páginasTM01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2024

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 02/12/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 56 Manor Road London N16 5BN England para 21 Minety Road Swindon Wiltshire SN2 5PQ

    1 páginasAD02

    Nomeação de Ms Gail Susan Booth como diretor em 06/12/2023

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr William Antony Mansfield como diretor em 06/12/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Christine Shauna Young como diretor em 09/09/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Penelope Norma Denby como diretor em 09/09/2023

    1 páginasTM01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2023

    3 páginasAA

    Nomeação de Ms Fiona Katrine Johnson como diretor em 21/06/2023

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/12/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Dr Vanessa Quick como diretor em 29/06/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Chetan Mukhtyar como diretor em 08/02/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Dorothy Byrne como diretor em 07/07/2022

    1 páginasTM01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2022

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 02/12/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 14 Piggott House Sewardstone Road London E2 9JJ England para 56 Manor Road London N16 5BN

    1 páginasAD02

    Quem são os diretores de POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MANNELL, Janette Elizabeth
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    Secretário
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    345785160001
    BASSENDINE, Margaret Fiona
    Great Whittington
    NE19 2HA Newcastle Upon Tyne
    Tynedale Lodge
    United Kingdom
    Diretor
    Great Whittington
    NE19 2HA Newcastle Upon Tyne
    Tynedale Lodge
    United Kingdom
    United KingdomBritish247123710001
    BOOTH, Gail Susan
    Bm Pmrgcauk
    12
    WC1N 3XX London
    27 Old Gloucester Street
    England
    Diretor
    Bm Pmrgcauk
    12
    WC1N 3XX London
    27 Old Gloucester Street
    England
    EnglandBritish162431350002
    HOLROYD, Geoffrey
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    Diretor
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    EnglandBritish126796120001
    JOHNSON, Fiona Katrine
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    Diretor
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    EnglandBritish310753880001
    MADDOCK, Janice Clare
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    Diretor
    Stoneleigh Avenue
    BN1 8NP Brighton
    15
    England
    EnglandBritish199341010002
    MANSFIELD, William Antony, Dr
    Bm Pmrgcauk
    12
    WC1N 3XX London
    27 Old Gloucester Street
    England
    Diretor
    Bm Pmrgcauk
    12
    WC1N 3XX London
    27 Old Gloucester Street
    England
    EnglandBritish281060140001
    QUICK, Vanessa, Dr
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    Diretor
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    EnglandBritish301254240001
    ANDERSON, David, The Honourable
    New South Terrace
    Birtley
    DH3 1AF Chester Le Street
    5
    County Durham
    Diretor
    New South Terrace
    Birtley
    DH3 1AF Chester Le Street
    5
    County Durham
    United KingdomBritish134960330001
    BOYLE, Lynne
    Woodmans Way
    Whickham
    NE16 5TR Newcastle Upon Tyne
    14
    United Kingdom
    Diretor
    Woodmans Way
    Whickham
    NE16 5TR Newcastle Upon Tyne
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish188254890001
    BYRNE, Dorothy
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    EnglandBritish203330140001
    DENBY, Penelope Norma
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    EnglandBritish67501630001
    GIBSON, John Arthur
    30 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    Diretor
    30 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritish94193480002
    GILBERT, Kathryn Margaret, Dr
    Avondale Road
    WV6 0AJ Wolverhampton
    54
    England
    Diretor
    Avondale Road
    WV6 0AJ Wolverhampton
    54
    England
    EnglandBritish157446090002
    HAMILTON, Robin Edward
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    United KingdomBritish117449100003
    HAMILTON, Robin
    House
    Sidlesham Lane Birdham
    PO20 7QL Chichester
    Woodhorn Farm
    West Sussex
    England
    Diretor
    House
    Sidlesham Lane Birdham
    PO20 7QL Chichester
    Woodhorn Farm
    West Sussex
    England
    EnglandBritish174196470001
    HODGSON, Humphrey Julian Francis, Professor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    EnglandBritish,Irish50431840001
    JEFFREY, Alison
    Lutley Close
    Lutley Close
    WV3 7EX Wolverhampton
    8
    England
    Diretor
    Lutley Close
    Lutley Close
    WV3 7EX Wolverhampton
    8
    England
    ScotlandBritish170250940001
    LEVENE, Wendy, Lady
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    EnglandBritish170250970001
    MACKIE, Sarah Louise
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    EnglandBritish203320470001
    MILLER, Isabel Jean
    Castleroy Road
    DD5 2LQ Broughty Ferry
    10
    Dundee
    Diretor
    Castleroy Road
    DD5 2LQ Broughty Ferry
    10
    Dundee
    ScotlandBritish147675530001
    MORRISON, Wendy Jane
    Elworthy Drive
    TA21 9AT Wellington
    1
    Somerset
    Diretor
    Elworthy Drive
    TA21 9AT Wellington
    1
    Somerset
    United KingdomBritish134960340001
    MUKHTYAR, Chetan, Dr
    Upton Close
    NR4 7PD Norwich
    12
    England
    Diretor
    Upton Close
    NR4 7PD Norwich
    12
    England
    EnglandBritish208020710001
    MULLER, Sara Nicole
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    Diretor
    London
    WC1N 3XX London
    Bm Pmrgcauk
    England
    EnglandBritish256865840001
    NOTT, Jennifer Fletcher
    Uvedale Gardens
    IP6 8BA Needham Market
    8
    Suffolk
    Diretor
    Uvedale Gardens
    IP6 8BA Needham Market
    8
    Suffolk
    United KingdomBritish147675170001
    PEASE, Colin, Dr
    Avondale Road
    WV6 0AJ Wolverhampton
    54
    England
    Diretor
    Avondale Road
    WV6 0AJ Wolverhampton
    54
    England
    United KingdomBritish170247790001
    PICKERSGILL, Catherine
    Carisbrooke Drive
    BN13 3QT Worthing
    25
    West Sussex
    England
    Diretor
    Carisbrooke Drive
    BN13 3QT Worthing
    25
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish188254170001
    ROBINSON, Edna Margaret
    3 The Spinney
    LA1 4JQ Lancaster
    Lancashire
    Diretor
    3 The Spinney
    LA1 4JQ Lancaster
    Lancashire
    British55610970001
    SARAVANAN, Vadivelu, Dr
    Beaumont Terrace
    Gosforth
    NE3 1AS Newcastle
    18
    Tyne And Wear
    Diretor
    Beaumont Terrace
    Gosforth
    NE3 1AS Newcastle
    18
    Tyne And Wear
    United KingdomIndian134960350001
    SIBLEY, Elizabeth Jayne
    Heath Road
    CV12 0BN Bedworth
    186
    Warwickshire
    Diretor
    Heath Road
    CV12 0BN Bedworth
    186
    Warwickshire
    United KingdomBritish134960360001
    SLATER, Keith John Peniston
    High Street
    Filkins
    GL7 3HU Lechlade
    The Post House
    England
    Diretor
    High Street
    Filkins
    GL7 3HU Lechlade
    The Post House
    England
    EnglandBritish178520280001
    SMITH, Mavis Ruth
    Kibblesworth
    NE11 0YJ Gateshead
    South Farm Cottage
    Tyne & Wear
    Diretor
    Kibblesworth
    NE11 0YJ Gateshead
    South Farm Cottage
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish147675290001
    WALKINGTON, Alan
    Deramore Drive
    Badger Hill
    YO10 5HW York
    5
    Yorkshire
    Diretor
    Deramore Drive
    Badger Hill
    YO10 5HW York
    5
    Yorkshire
    United KingdomBritish134960370001
    YOUNG, Christine Shauna
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    Diretor
    Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    10
    England
    EnglandBritish203319980001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para POLYMYALGIA RHEUMATICA AND GIANT CELL ARTERITIS UK?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    02/12/2016A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0