MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD

MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 08033025
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    • coleta de resíduos não perigosos (38110) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação
    • tratamento e disposição de resíduos não perigosos (38210) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação
    • recuperação de materiais classificados (38320) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação

    Onde fica MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Suez House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SITA SEMBCORP UK LIMITED30/04/201230/04/2012
    SHUKCO 312A LIMITED17/04/201217/04/2012

    Quais são as últimas contas de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2026
    Próximas contas vencem em31/12/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2025

    Qual é o status da última declaração de confirmação para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Última declaração de confirmação elaborada até17/04/2027
    Próxima declaração de confirmação vence01/05/2027
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até17/04/2026
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2026 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr. Richard Geoffrey Little como diretor em 30/11/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Daniel Geoffrey North como diretor em 30/11/2025

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2025

    36 páginasAA

    Término da nomeação de Philip Bruce Sheffer como diretor em 25/04/2025

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr. David Anthony Morris como diretor em 07/05/2025

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2025 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr. Iqbal Singh Sidhu como diretor em 20/02/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Michael Thomas Patrick como diretor em 20/02/2025

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr. Philip Bruce Sheffer como diretor em 20/02/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew John Cottrell como diretor em 31/12/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr. Daniel North como diretor em 15/08/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr. Neil Rae como diretor em 15/08/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kazuma Fukao como diretor em 15/08/2024

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Rahul Dipinkumar Kadiwar como diretor em 15/08/2024

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2024

    36 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr. Andrew John Cottrell como diretor em 01/12/2023

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2023

    36 páginasAA

    Término da nomeação de Belinda Faith Knox como diretor em 01/09/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Rahul Dipinkumar Kadiwar como diretor em 01/09/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Keith Thompson como diretor em 31/07/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Masashi Kanai como diretor em 01/04/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Kazuma Fukao como diretor em 01/04/2023

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Secretário
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro02291198
    114869260003
    LITTLE, Richard Geoffrey, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Diretor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish151062990002
    MORRIS, David Anthony, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish335522840001
    PADFIELD, Amanda
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159090300001
    RAE, Neil, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Diretor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    United KingdomBritish119437600003
    SIDHU, Iqbal Singh, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish332910240001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish162837220002
    THORN, Christopher Derrick
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish266799220001
    KNIGHT, Joan
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Secretário
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    168388440001
    AHMAD, Nauman
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandPakistani246516040001
    ANNAN, Douglas Stuart, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish165609970001
    BONE, Dugald John, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish84834380001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandFrench122645500003
    CHONG, Kwong Fatt
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Diretor
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    SingaporeSingaporean183833580001
    COTTRELL, Andrew John
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish334057500001
    FUKAO, Kazuma
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Diretor
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese308897090001
    GAVIN, Paul
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159027960001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Diretor
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish205116300001
    HIBINO, Tsuneharu
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandJapanese168730210001
    HIGASHIYAMA, Eiichiro
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    Diretor
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    EnglandJapanese195916850001
    KADIWAR, Rahul Dipinkumar
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    Diretor
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish313395690001
    KANAI, Masashi
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Diretor
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese282813470002
    KNOX, Belinda Faith
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Diretor
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish190578640001
    MCCLAY, Catherine Isabel, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish245734420001
    MCKENNA-MAYES, Graham Arthur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91435430011
    NG, Meng Poh
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    SingaporeSingaporean150975730001
    NORTH, Daniel Geoffrey
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Diretor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish259587080001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish125070620001
    PATRICK, Michael Thomas
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish293354340001
    SCRIMSHAW, Matthew Giles
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish265146200001
    SEXTON, Ian Anthony
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Diretor
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    FranceBritish182259120001
    SHEFFER, Philip Bruce, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish332909490001
    SUZUKI, Yuji
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Diretor
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese236854110002
    THOMPSON, David Keith
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish265146580001

    Quem são as pessoas com controle significativo de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    06/04/2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro07983197
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0