J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.
Visão geral
| Nome da empresa | J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. |
|---|---|
| Estado da empresa | Convertida/Fechada |
| Forma jurídica | Sociedade estrangeira |
| Número da empresa | FC010020 |
| Jurisdição | Reino Unido |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Onde fica J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Endereço do escritório registrado | 270 Park Avenue New York New York Ny10017 United States |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MORGAN GUARANTY LIMITED | 27/06/1979 | 27/06/1979 |
Quais são as últimas contas de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2015 |
J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. é uma empresa estrangeira
| Requisitos contábeis para empresas estrangeiras | |
|---|---|
| Tipo de conta estrangeira | Não são aplicáveis os requisitos contabilísticos do país de origem |
| Condições de publicação das contas | Data de referência contabilística atribuída pela Companies House |
| Atividade comercial | Securities Business & Arranging Interest Rate Swaps |
| Forma jurídica | Limited Liability |
| É uma instituição de crédito ou financeira | Não |
| Regido por | State Of Delaware, Usa |
| País de origem do registro | UNITED STATES |
| Local de registro | Office Of Secretary Of State, State Of Delaware |
| Número da empresa | N/A |
Quais são as últimas submissões para J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Encerramento do(s) estabelecimento(s) britânico(s) BR001994 e da sociedade estrangeira FC010020 em 26/05/2017 | 2 páginas | OSDS01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 13 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Timothy James Osborne Throsby como diretor em 05/09/2016 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Nomeação de David Alan Thompson como pessoa autorizada a aceitar serviço para o estabelecimento no Reino Unido BR001994 em 26/02/2016. | 2 páginas | OSAP07 | ||
Término da nomeação para um estabelecimento do Reino Unido - Transaction OSTM03- BR001994 Person Authorised to Accept terminated 26/02/2016 yeng yeng maxwell | 2 páginas | OSTM03 | ||
Nomeação de Abdelfater Belbachir como diretor em 14/12/2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Jason Edwin Sippel em 08/01/2016 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Nomeação de Christopher Louis Berthe como diretor em 14/12/2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Timothy James Osborne Throsby em 01/09/2014 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Detalhes do diretor alterados para Jason Sippel em 01/09/2015 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Nomeação de Paul Francis Brannan como diretor em 15/12/2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Alteração dos documentos constitutivos" em 05/08/2010 | 18 páginas | OSCC01 | ||
Detalhes alterados para uma sociedade estrangeira - Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Usa | 4 páginas | OSCH02 | ||
Término da nomeação de Mary Frances Vance como secretário em 14/12/2015 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Término da nomeação de Yeng Yeng Maxwell como secretário em 14/12/2015 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 16 páginas | AA | ||
Término da nomeação de John Horner como diretor em 17/04/2015 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Nomeação de Jeffrey Lipman como secretário em 13/02/2015 | 3 páginas | OSAP03 | ||
Término da nomeação de Carlos Hernandez como diretor em 03/10/2014 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Término da nomeação de Colleen Anne Meade como secretário em 01/12/2008 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 16 páginas | AA | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2012 | 17 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Andrea Angelone como diretor | 2 páginas | OSTM01 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2011 | 16 páginas | AA | ||
Nomeação de Yeng Yeng Maxwell como pessoa autorizada a aceitar serviço para o estabelecimento no Reino Unido BR001994 em 06/07/2012. | 2 páginas | OSAP07 | ||
Quem são os diretores de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPMAN, Jeffrey | Secretário | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 Uk | British | 195536750001 | ||||||
| BELBACHIR, Abdelfater | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Ney York United States Of America | French | 205119510001 | |||||
| BERTHE, Christopher Louis | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | New York United States Of America | American | 204669420001 | |||||
| BRANNAN, Paul Francis | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Connecticut United States Of America | British | 92879690002 | |||||
| SIPPEL, Jason Edwin | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | United Kingdom | British | 149482060002 | |||||
| BERRY, James Clifford Pierce | Secretário | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 79713580002 | ||||||
| LAWSON, Jane Elizabeth | Secretário | 2a Lee Terrace Blackheath SE3 9TZ London | British | 47291860001 | ||||||
| MAXWELL, Yeng Yeng | Secretário | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 66736370004 | ||||||
| MEADE, Colleen Anne | Secretário | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 116239730001 | ||||||
| SAMSON, Timothy Hugh | Secretário | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 97409050002 | ||||||
| SZYPULA, Richard Michael | Secretário | 2 Hobart Street FOREIGN Bronxville Ny 10708 Usa | Usa | 30009470001 | ||||||
| VANCE, Mary Frances | Secretário | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 96140800001 | ||||||
| ANGELONE, Andrea Giovanni | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | Italian | 98441580003 | ||||||
| BRANDOW, Paul | Diretor | 135 East. 74th St.,Apt.5b New York Ny 10021 Usa | Usa | 92167650001 | ||||||
| BRETT, James | Diretor | 16 Birch Lane Greenwich Ct 06830 Usa | American | 93166600001 | ||||||
| CHRISTIAN JEAN LOUIS, Dalban | Diretor | 5 Courtfield Mews SW5 0NH London | French | 76710380002 | ||||||
| COLAS, Oliver | Diretor | 58 Chelsea Park Gardens SW3 London | French | 47291830001 | ||||||
| CORRIE, John Richard Duncan | Diretor | Sullingstead Hascombe Road GU8 4AE Godalming Surrey | England | British | 80720100001 | |||||
| DELUCA, John Charles | Diretor | London Wall EC2Y 5AJ London 125 | Usa | American | 149482670001 | |||||
| ENTHOVEN, Michael | Diretor | 60 Otter Rock Drive Greenwich Connecticut 06830 Usa | Dutch | 31709610001 | ||||||
| GRAY, Robert Blackburn | Diretor | 9 St Simons Avenue SW15 6DU London | England | British | 26727060001 | |||||
| GUBERT, Walter Alexander | Diretor | 14 Edwardes Square W8 6HE London | Italian | 28886800001 | ||||||
| HENDRICKS, Maureen Agnes | Diretor | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | American | 47292200001 | ||||||
| HERNANDEZ, Carlos | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | American | 93166670001 | ||||||
| HORNER, John | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | United States | American | 170579190001 | |||||
| LONG, David Nicholas | Diretor | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | British | 98441570003 | ||||||
| LOWE, Claus | Diretor | 16 Marryat Road SW19 5BD Wimbledon London | German | 47292190002 | ||||||
| LYALL, Ian Robert | Diretor | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | England | British | 181859690001 | |||||
| MAYER, JR, John Anton | Diretor | 7 Upland Drive Greenwich Connecticut 06831 Usa | American | 47291850001 | ||||||
| MEIER, Marcus | Diretor | 109 Bank Street New York New York 10014 Usa | Swiss | 47292180001 | ||||||
| MOSES, Menasey Marc | Diretor | 16 Crespigny Road NW4 3DY London | British | 68184260001 | ||||||
| PATTERSON, Michael Ellmore | Diretor | 530 East 86th Street 10021 New York New York 10028 Usa | American | 47292170001 | ||||||
| PINILLA, Juan-Carlos | Diretor | 75e 75th Street New York Ny 10021 Usa | Spanish | 92629140001 | ||||||
| SAIER, George Arnaud | Diretor | 46 Holland Street W8 4LX London | French | 102990210001 | ||||||
| THROSBY, Timothy James Osborne | Diretor | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | England | Australian | 170579950001 |
J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Securities pledge agreement | Criado em 23/12/2003 Entregue em 09/01/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The securities pledge agreement creates security over the 'pledged collateral'. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge | Criado em 09/01/1992 Entregue em 14/01/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All shares,stock and other securities of any description for the time being desinated by the stock exchange as talisman securities time to time registered in the name of or comprised in a transfer of any nominee company (see form 395 document m 30C for full details.). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed | Criado em 31/03/1988 Entregue em 08/04/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição Fixed charge all sums from time to time deposited by the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Security agreement | Criado em 31/03/1988 Entregue em 08/04/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company morgan guaranty trust company of new york under or in respect of the "secured sums" (as defined in the terms of the charge | |
Breve descrição All rights,claims and interests of the company in and to the stocks/shares (please see form 395 for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0