J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.

J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.

  • Visão geral
  • Resumo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Empresa estrangeira
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJ.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.
    Estado da empresaConvertida/Fechada
    Forma jurídicaSociedade estrangeira
    Número da empresa FC010020
    JurisdiçãoReino Unido
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Onde fica J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?

    Endereço do escritório registrado
    270 Park Avenue
    New York
    New York Ny10017
    United States
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MORGAN GUARANTY LIMITED27/06/197927/06/1979

    Quais são as últimas contas de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. é uma empresa estrangeira

    Requisitos contábeis para empresas estrangeiras
    Tipo de conta estrangeiraNão são aplicáveis os requisitos contabilísticos do país de origem
    Condições de publicação das contasData de referência contabilística atribuída pela Companies House
    Atividade comercialSecurities Business & Arranging Interest Rate Swaps
    Forma jurídicaLimited Liability
    É uma instituição de crédito ou financeiraNão
    Regido porState Of Delaware, Usa
    País de origem do registroUNITED STATES
    Local de registroOffice Of Secretary Of State, State Of Delaware
    Número da empresaN/A

    Quais são as últimas submissões para J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Encerramento do(s) estabelecimento(s) britânico(s) BR001994 e da sociedade estrangeira FC010020 em 26/05/2017

    2 páginasOSDS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    13 páginasAA

    Término da nomeação de Timothy James Osborne Throsby como diretor em 05/09/2016

    2 páginasOSTM01

    Nomeação de David Alan Thompson como pessoa autorizada a aceitar serviço para o estabelecimento no Reino Unido BR001994 em 26/02/2016.

    2 páginasOSAP07

    Término da nomeação para um estabelecimento do Reino Unido - Transaction OSTM03- BR001994 Person Authorised to Accept terminated 26/02/2016 yeng yeng maxwell

    2 páginasOSTM03

    Nomeação de Abdelfater Belbachir como diretor em 14/12/2015

    3 páginasOSAP01

    Detalhes do diretor alterados para Jason Edwin Sippel em 08/01/2016

    3 páginasOSCH03

    Nomeação de Christopher Louis Berthe como diretor em 14/12/2015

    3 páginasOSAP01

    Detalhes do diretor alterados para Timothy James Osborne Throsby em 01/09/2014

    3 páginasOSCH03

    Detalhes do diretor alterados para Jason Sippel em 01/09/2015

    3 páginasOSCH03

    Nomeação de Paul Francis Brannan como diretor em 15/12/2015

    3 páginasOSAP01

    Alteração dos documentos constitutivos" em 05/08/2010

    18 páginasOSCC01

    Detalhes alterados para uma sociedade estrangeira - Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Usa

    4 páginasOSCH02

    Término da nomeação de Mary Frances Vance como secretário em 14/12/2015

    2 páginasOSTM02

    Término da nomeação de Yeng Yeng Maxwell como secretário em 14/12/2015

    2 páginasOSTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    16 páginasAA

    Término da nomeação de John Horner como diretor em 17/04/2015

    2 páginasOSTM01

    Nomeação de Jeffrey Lipman como secretário em 13/02/2015

    3 páginasOSAP03

    Término da nomeação de Carlos Hernandez como diretor em 03/10/2014

    2 páginasOSTM01

    Término da nomeação de Colleen Anne Meade como secretário em 01/12/2008

    2 páginasOSTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    16 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    17 páginasAA

    Término da nomeação de Andrea Angelone como diretor

    2 páginasOSTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    16 páginasAA

    Nomeação de Yeng Yeng Maxwell como pessoa autorizada a aceitar serviço para o estabelecimento no Reino Unido BR001994 em 06/07/2012.

    2 páginasOSAP07

    Quem são os diretores de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LIPMAN, Jeffrey
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Uk
    Secretário
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Uk
    British195536750001
    BELBACHIR, Abdelfater
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Ney York United States Of AmericaFrench205119510001
    BERTHE, Christopher Louis
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    New York United States Of AmericaAmerican204669420001
    BRANNAN, Paul Francis
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United Kingdom
    Connecticut United States Of AmericaBritish92879690002
    SIPPEL, Jason Edwin
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    United KingdomBritish149482060002
    BERRY, James Clifford Pierce
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Secretário
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    American79713580002
    LAWSON, Jane Elizabeth
    2a Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    Secretário
    2a Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    British47291860001
    MAXWELL, Yeng Yeng
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secretário
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British66736370004
    MEADE, Colleen Anne
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secretário
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British116239730001
    SAMSON, Timothy Hugh
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Secretário
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    American97409050002
    SZYPULA, Richard Michael
    2 Hobart Street
    FOREIGN Bronxville
    Ny 10708
    Usa
    Secretário
    2 Hobart Street
    FOREIGN Bronxville
    Ny 10708
    Usa
    Usa30009470001
    VANCE, Mary Frances
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Secretário
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    British96140800001
    ANGELONE, Andrea Giovanni
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Italian98441580003
    BRANDOW, Paul
    135 East. 74th St.,Apt.5b
    New York
    Ny
    10021
    Usa
    Diretor
    135 East. 74th St.,Apt.5b
    New York
    Ny
    10021
    Usa
    Usa92167650001
    BRETT, James
    16 Birch Lane
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    Diretor
    16 Birch Lane
    Greenwich
    Ct 06830
    Usa
    American93166600001
    CHRISTIAN JEAN LOUIS, Dalban
    5 Courtfield Mews
    SW5 0NH London
    Diretor
    5 Courtfield Mews
    SW5 0NH London
    French76710380002
    COLAS, Oliver
    58 Chelsea Park Gardens
    SW3 London
    Diretor
    58 Chelsea Park Gardens
    SW3 London
    French47291830001
    CORRIE, John Richard Duncan
    Sullingstead
    Hascombe Road
    GU8 4AE Godalming
    Surrey
    Diretor
    Sullingstead
    Hascombe Road
    GU8 4AE Godalming
    Surrey
    EnglandBritish80720100001
    DELUCA, John Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    Diretor
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    UsaAmerican149482670001
    ENTHOVEN, Michael
    60 Otter Rock Drive
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Diretor
    60 Otter Rock Drive
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Dutch31709610001
    GRAY, Robert Blackburn
    9 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    Diretor
    9 St Simons Avenue
    SW15 6DU London
    EnglandBritish26727060001
    GUBERT, Walter Alexander
    14 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Diretor
    14 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Italian28886800001
    HENDRICKS, Maureen Agnes
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    Diretor
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    American47292200001
    HERNANDEZ, Carlos
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    American93166670001
    HORNER, John
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    United StatesAmerican170579190001
    LONG, David Nicholas
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Diretor
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    British98441570003
    LOWE, Claus
    16 Marryat Road
    SW19 5BD Wimbledon
    London
    Diretor
    16 Marryat Road
    SW19 5BD Wimbledon
    London
    German47292190002
    LYALL, Ian Robert
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    Diretor
    125 London Wall
    EC2Y 5AJ London
    EnglandBritish181859690001
    MAYER, JR, John Anton
    7 Upland Drive
    Greenwich
    Connecticut 06831
    Usa
    Diretor
    7 Upland Drive
    Greenwich
    Connecticut 06831
    Usa
    American47291850001
    MEIER, Marcus
    109 Bank Street
    New York
    New York 10014
    Usa
    Diretor
    109 Bank Street
    New York
    New York 10014
    Usa
    Swiss47292180001
    MOSES, Menasey Marc
    16 Crespigny Road
    NW4 3DY London
    Diretor
    16 Crespigny Road
    NW4 3DY London
    British68184260001
    PATTERSON, Michael Ellmore
    530 East 86th Street
    10021 New York
    New York 10028
    Usa
    Diretor
    530 East 86th Street
    10021 New York
    New York 10028
    Usa
    American47292170001
    PINILLA, Juan-Carlos
    75e 75th Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Diretor
    75e 75th Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Spanish92629140001
    SAIER, George Arnaud
    46 Holland Street
    W8 4LX London
    Diretor
    46 Holland Street
    W8 4LX London
    French102990210001
    THROSBY, Timothy James Osborne
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    Diretor
    Bank Street
    Canary Wharf
    E14 5JP London
    25
    England
    EnglandAustralian170579950001

    J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Securities pledge agreement
    Criado em 23/12/2003
    Entregue em 09/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The securities pledge agreement creates security over the 'pledged collateral'. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • U.S. Bank Trust National Association
    Transações
    • 09/01/2004Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 09/01/1992
    Entregue em 14/01/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All shares,stock and other securities of any description for the time being desinated by the stock exchange as talisman securities time to time registered in the name of or comprised in a transfer of any nominee company (see form 395 document m 30C for full details.).
    Pessoas com direito
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited.
    Transações
    • 14/01/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/02/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed
    Criado em 31/03/1988
    Entregue em 08/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Fixed charge all sums from time to time deposited by the company.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 08/04/1988Registro de uma garantia
    • 17/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 31/03/1988
    Entregue em 08/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company morgan guaranty trust company of new york under or in respect of the "secured sums" (as defined in the terms of the charge
    Breve descrição
    All rights,claims and interests of the company in and to the stocks/shares (please see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 08/04/1988Registro de uma garantia
    • 17/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0