SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC015365 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | TENEO FINANCIAL ADVISORY LIMITED 100 West George Street G2 1PJ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Conta final antes da dissolução em MVL (conta final anexa) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Clyde & Co Albany House 58 Albany Street Edinburgh Scotland EH1 3QR Scotland para 100 West George Street Glasgow G2 1PJ em 03/05/2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado do capital em 09/12/2022
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Louise Margaret Dinnage como diretor em 21/03/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Benjamin Williams como diretor em 21/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Cms Cameron Mckenna Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh Scotland EH1 2EN Scotland para Clyde & Co Albany House 58 Albany Street Edinburgh Scotland EH1 3QR em 31/01/2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 18/03/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Dundas & Wilson Cs Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh Scotland EH1 2EN para Cms Cameron Mckenna Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh Scotland EH1 2EN em 18/03/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Lynette Jean Cherryl Carter como secretário em 31/05/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/03/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Lynette Jean Cherryl Carter como secretário em 14/06/2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Quem são os diretores de SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALLEY, Michael, Dr | Diretor | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Dundas & Wilson Cs Llp Scotland | United Kingdom | British | 195518140001 | |||||
| WILLIAMS, Benjamin | Diretor | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | United Kingdom | British | 273979270001 | |||||
| CARTER, Lynette Jean Cherryl | Secretário | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 233749060001 | |||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Secretário | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | 34645590005 | ||||||
| CLARK, Lynda | Secretário | 2 Melton Road WA7 4AH Runcorn Cheshire | British | 18943600004 | ||||||
| HARDIE, David | Secretário | 15 Howard Place EH3 5JZ Edinburgh | British | 47948570001 | ||||||
| HORLOCK, Elizabeth Ann | Secretário | 1 Barringer Court London Street, Godmanchester PE29 2HU Huntingdon Cambs | British | 110831950002 | ||||||
| IRVINE, Scott Macdonald | Secretário | 69 Streatham Court Streatham High Road SW16 1DJ London | British | 79545730002 | ||||||
| KING, Ian | Secretário | 4 Liddesdale Place EH3 5JW Edinburgh Midlothian | British | 48860001 | ||||||
| ROSS, Ian Alexander | Secretário | 77 Nether Currie Crescent EH14 5JH Currie Midlothian | British | 56270001 | ||||||
| TURNER, George St John | Secretário | The Manse Main Street PE28 0QR Bythorn Cambridgeshire | British | 88865090002 | ||||||
| WHITESIDE, Sonia Jane | Secretário | 139 Amhurst Road E8 2AW London | British | 71755560003 | ||||||
| WINCHESTER, Emma | Secretário | The Coach House 173a Merton Road SW19 1EE London | British | 95340090006 | ||||||
| O.H. SECRETARIAT LIMITED | Secretário | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 129226660002 | |||||||
| ATKINS, Kenneth Thomas George | Diretor | 2 Mount Parade YO2 4AP York | British | 38713060001 | ||||||
| ATTRILL, Geoffrey George | Diretor | Ellwood Cross Tree Lane CH5 3PY Hawarden Deeside | British | 8545780001 | ||||||
| BAKER, John Stewart Lawson | Diretor | Norfolk Lodge 114 Richmond Hill TW10 6RJ Richmond Surrey | British | 66422970001 | ||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Diretor | C/O Kpmg Saltire Court EH1 2EG 20 Castle Terrace Edinburgh | British | 34645590005 | ||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Diretor | 19 Wellsmoor Gardens BR1 2HT Bickley Kent | British | 34645590005 | ||||||
| CLARK, Lynda | Diretor | 2 Melton Road WA7 4AH Runcorn Cheshire | British | 18943600004 | ||||||
| DEVIN, Mark | Diretor | 2 The Green CM23 3ER Bishops Stortford Hertfordshire | British | 13369860004 | ||||||
| DINNAGE, Louise Margaret | Diretor | Albany House 58 Albany Street EH1 3QR Edinburgh Clyde & Co Scotland Scotland | United Kingdom | British | 196955920001 | |||||
| ECKERSALL, Richard Norman | Diretor | 15-17 Lanark Road West EH14 5ES Currie Midlothian | British | 56310001 | ||||||
| FREW, Alan Dalziel | Diretor | The White House Chinnor Road HP14 4AA Bledlow Ridge Buckinghamshire | British | 8545790005 | ||||||
| GROSSET, Margaret Wilhelmina | Diretor | 7 Arnprior Place KA7 4PT Alloway Ayrshire | British | 54009620001 | ||||||
| GWYNNE-JONES, Andrew Keith | Diretor | Ellinor House Front Street Hutton Henry TS27 4RH Hartlepool Cleveland | British | 39597300001 | ||||||
| HORLOCK, Elizabeth Ann | Diretor | 1 Barringer Court London Street, Godmanchester PE29 2HU Huntingdon Cambs | British | 110831950002 | ||||||
| IRVINE, Scott Macdonald | Diretor | 69 Streatham Court Streatham High Road SW16 1DJ London | British | 79545730002 | ||||||
| KAY, John Lawrence | Diretor | Wabun Garbutts Lane Hutton Rudby TS15 0DL Yarm Cleveland | England | British | 20420080001 | |||||
| KING, Deryk Irving | Diretor | Handley Cross Leven Bank TS15 9JL Yarm Cleveland | British | 46700910001 | ||||||
| MARSDEN, Paul | Diretor | The Croft Clack Lane, Osmotherly DL6 3PP Northallerton North Yorkshire | British | 125919730001 | ||||||
| PATON, Nigel Robert | Diretor | 19 Broadwell Court NE3 1YS Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 70835780001 | ||||||
| REID, Robert Mackenzie Cowan | Diretor | Jalala 18 West Harbour Road Charlestown KY11 3ET Dunfermline Fife | British | 56330001 | ||||||
| SHOVLIN, Thomas Anthony | Diretor | 23 Forest Lane Kirklevington TS15 9LX Yarm Cleveland | British | 56330750001 | ||||||
| TONGE, Malcolm | Diretor | 65 Belmont Avenue Brookfield TS5 8EW Middlesbrough Cleveland | British | 53399970001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ici Chemicals & Polymers Limited | 20/05/2016 | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0