JOHNSTON PRESS PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaJOHNSTON PRESS PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa SC015382
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de JOHNSTON PRESS PLC?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica JOHNSTON PRESS PLC?

    Endereço do escritório registrado
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de JOHNSTON PRESS PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    F. JOHNSTON & COMPANY LIMITED31/12/192831/12/1928

    Quais são as últimas contas de JOHNSTON PRESS PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/12/2017

    Quais são as últimas submissões para JOHNSTON PRESS PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Conta final antes da dissolução numa liquidação judicial

    19 páginasWU15(Scot)

    Ordem judicial numa liquidação (& Anexo da ordem judicial)

    6 páginasWU01(Scot)

    Despacho judicial

    Order of court - dissolution void
    2 páginasOC-DV

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Mudança da administração para dissolução

    34 páginasAM23(Scot)

    Relatório de progresso do administrador

    33 páginasAM10(Scot)

    Aviso de extensão do período de administração

    5 páginasAM19(Scot)

    Relatório de progresso do administrador

    35 páginasAM10(Scot)

    Término da nomeação de Peter Mccall como secretário em 17/05/2019

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de David John King como diretor em 17/05/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Kjell Aamot como diretor em 01/01/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 19/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Michael Guy Butterworth como diretor em 19/02/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Camilla Alexandra Rhodes como diretor em 09/01/2019

    1 páginasTM01

    Declaração da proposta considerada do administrador

    1 páginas2.16BZ(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS para 272 Bath Street Glasgow G2 4JR em 06/12/2018

    2 páginasAD01

    Declaração da proposta do administrador

    119 páginas2.16B(Scot)

    Declaração de negócios com formulário 2.13B(Scot)

    12 páginas2.15B(Scot)

    Nomeação de um administrador

    2 páginas2.11B(Scot)

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 9

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    4 páginasMR04

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Genera meeting of company called not less 14 clear days notice 05/06/2018
    RES13

    Quem são os diretores de JOHNSTON PRESS PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Secretário
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    British474360001
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretário
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secretário
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146630180001
    AAMOT, Kjell
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    NorwayNorwegian153114510002
    BELL, Iain William
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    Diretor
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    British35563110001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Diretor
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    BUCHAN, William James
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Diretor
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    EnglandBritish232628330001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish76600500002
    CAMMIADE, Danny
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    Diretor
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    EnglandBritish251394160001
    CAWDRON, Peter Edward Blackburn
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Diretor
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandBritish166325310001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Diretor
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Diretor nomeado
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    DUNN, Hugh John Ramsay
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    Diretor
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    British328340001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Diretor
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HALE, Matthew Joseph Hovey
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    Diretor
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    British7129870001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    HINTON, Leslie Frank
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    Diretor
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    British104267650003
    IDDISON, Geoff
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    Diretor
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    United KingdomBritish148074460002
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    Diretor
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    British328390002
    JOHNSTON, Henry Charles Marriott
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    Diretor
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    British474380004
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    KING, Martina Ann
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Diretor
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    British107699510001
    MARSHALL, Augustus Ralph
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    Diretor
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    MalaysiaMalaysian16432070011
    MERRILLS, Austin
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    Diretor
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    British529310002
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Diretor
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    PAIN, Mark Andrew
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish122498680001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Diretor
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritish41614380002
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    PATTERSON, Gavin Echlin
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    Diretor
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    British131233950001
    RHODES, Camilla Alexandra
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    British139644420001
    ROCHE, Henry John, Sir
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    Diretor
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    British53613320001
    RUDD-JONES, Nicholas
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    Diretor
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    British77152150002
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003
    THE LORD GORDON OF STRATHBLANE
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    Diretor
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    British312680002
    VAN ROOYEN, Stephen John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Diretor
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish178722710001

    JOHNSTON PRESS PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 23/06/2014
    Entregue em 04/07/2014
    Pendente
    Breve descrição
    All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 04/07/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 23/06/2014
    Entregue em 04/07/2014
    Pendente
    Breve descrição
    The extent that title to the real property in northern ireland freehold tenure see form for further details.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 04/07/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 16/06/2014
    Entregue em 24/06/2014
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag, London Branch for Itself and as Security Agent
    Transações
    • 24/06/2014Registro de uma garantia (MR01)
    Security agreement
    Criado em 25/09/2009
    Entregue em 06/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/10/2009Registro de uma garantia (MG01s)
    • 10/05/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 12/10/2013Parte do imóvel ou empresa foi liberada da garantia (MR05)
    • 28/08/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Supplemantal legal mortgage
    Criado em 25/09/2009
    Entregue em 06/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Kings road, bury st edmonds, suffolk P212269 SK200901; 10/11 union street, wisbech, cambridgeshire; 46 high street, grantham, lincolnshire LL85306; oundle road, woodston ind est, peterborough CB233925.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/10/2009Registro de uma garantia (MG01s)
    • 28/08/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 28/08/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 10/05/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 12/10/2013Parte do imóvel ou empresa foi liberada da garantia (MR05)
    • 28/08/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Deposit agreement and cash deposit pledge
    Criado em 09/08/2005
    Entregue em 23/08/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due under or in connection with clause 5.2.2. under the credit agreement
    Breve descrição
    The company pledges and assigns the deposit account and the deposit and all the present and future rights, titles and benefit of the company in the deposit account and the deposit.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 23/08/2005Registro de uma garantia (410)
    • 27/06/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 12/04/2002
    Entregue em 30/04/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 30/04/2002Registro de uma garantia (410)
    • 26/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • 12/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 25/06/1999
    Entregue em 06/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 06/07/1999Registro de uma garantia (410)
    • 27/06/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 01/07/1996
    Entregue em 19/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself and as Trustee for Others
    Transações
    • 19/07/1996Registro de uma garantia (410)
    • 08/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 18/10/1978
    Entregue em 26/10/1978
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 26/10/1978Registro de uma garantia
    • 11/12/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    JOHNSTON PRESS PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    17/11/2018Início da administração
    15/06/2020Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Profissional
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profissional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profissional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profissional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    2
    DataTipo
    09/03/2023Conclusão da liquidação
    19/05/2021Data da petição
    11/07/2023Data prevista de dissolução
    19/05/2021Início da liquidação
    Liquidação compulsória
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profissional
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profissional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0