HANOVER FOUR LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHANOVER FOUR LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC015674
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HANOVER FOUR LIMITED?

    • (9999) /

    Onde fica HANOVER FOUR LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HANOVER FOUR LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    THOMSON BROTHERS LTD.06/06/199406/06/1994
    THOMSON BROTHERS (KIRKCALDY) LIMITED16/08/192916/08/1929

    Quais são as últimas contas de HANOVER FOUR LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até25/02/2010

    Quais são as últimas submissões para HANOVER FOUR LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Nomeação de Mr Simon Terence Douglas como diretor em 14/11/2011

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Philip Hedley Bowcock como diretor em 14/11/2011

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 13/08/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/08/2011

    Estado do capital em 15/08/2011

    • Capital: GBP 21,412
    SH01

    Término da nomeação de Timothy O'gorman como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Philip Hedley Bowcock como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Jayne Fearn como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Timothy O'gorman como secretário

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 25/02/2010

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 13/08/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Término da nomeação de Andrew Marks como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Luminar Leisure Limited como diretor

    2 páginasAP02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 26/02/2009

    8 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Contas preparadas até 28/02/2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Contas preparadas até 01/03/2007

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Contas preparadas até 02/03/2006

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Quem são os diretores de HANOVER FOUR LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158739440001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Diretor
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro03802937
    152179970001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secretário
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secretário
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Secretário
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Secretário
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secretário
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretário
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secretário
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secretário
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Diretor
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Diretor
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Diretor
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COOK, John
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    Diretor
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    ScotlandBritish1388150003
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Diretor
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    GARVIE, David Campbell
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    Diretor
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    British4668490001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Diretor
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    British6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    JUDGE, Michael
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    Diretor
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    British653260001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Diretor
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Diretor
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MALCOLM, Alexander Ramsay
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    Diretor
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    ScotlandBritish66254130001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Diretor
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Diretor
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Diretor
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    PRENTICE, William
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    Diretor
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    British653270001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Diretor
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Diretor
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Diretor
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    HANOVER FOUR LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Bond & floating charge
    Criado em 07/02/1995
    Entregue em 23/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 23/02/1995Registro de uma garantia (410)
    • 06/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of offset
    Criado em 16/08/1982
    Entregue em 31/08/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by t s forster & sons LTD
    Breve descrição
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 31/08/1982Registro de uma garantia
    • 06/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of offset
    Criado em 19/03/1982
    Entregue em 06/04/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due, or to become due by park naval engineering LTD
    Breve descrição
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/04/1982Registro de uma garantia
    • 06/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of offset
    Criado em 09/02/1981
    Entregue em 13/02/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by robt. Balbirnie & company LTD and/or another
    Breve descrição
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/02/1981Registro de uma garantia
    • 06/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of offset
    Criado em 13/03/1979
    Entregue em 22/03/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by fife forester LTD and/or others
    Breve descrição
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by bank of scotland in name of thomson brothers (kirkcaldy) LTD.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 22/03/1979Registro de uma garantia
    • 06/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0