VION SUBCO MD LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaVION SUBCO MD LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC030556
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de VION SUBCO MD LIMITED?

    • Outras atividades de serviços n.e.c. (96090) / Outras atividades de serviços

    Onde fica VION SUBCO MD LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de VION SUBCO MD LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MCINTOSH DONALD LIMITED06/03/198906/03/1989
    WILLIAM DONALD & SON (WHOLESALE MEAT CONTRACTORS) LIMITED31/01/195531/01/1955

    Quais são as últimas contas de VION SUBCO MD LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2014
    Próximas contas vencem em30/09/2015
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para VION SUBCO MD LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Ata da reunião final da liquidação voluntária

    9 páginas4.26(Scot)
    S5XLYRL6

    Diversos

    Section 519
    1 páginasMISC
    A45KA35U

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA para C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX em 23/04/2015

    2 páginasAD01
    S45UVQDV

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 10/04/2015

    LRESSP

    Estado do capital em 24/02/2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19
    S41WBDIP

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    S41WBDOI

    legacy

    1 páginasSH20
    S41WBDOQ

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium account reduced 23/02/2015
    RES13

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    11 páginasAA
    A3LO77MO

    Declaração anual preparada até 30/09/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/11/2014

    Estado do capital em 04/11/2014

    • Capital: GBP 1,978,570
    SH01
    X3JYZX5S

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    11 páginasAA
    A30U1QBF

    Satisfação total da garantia 15

    6 páginasMR04
    S2ZMJZT4

    Satisfação total da garantia 14

    6 páginasMR04
    S2ZMJZV4

    Endereço do domicílio registado alterado de * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* em 12/12/2013

    1 páginasAD01
    X2N22M4A

    Declaração anual preparada até 30/09/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/10/2013

    Estado do capital em 09/10/2013

    • Capital: GBP 1,978,570
    SH01
    X2ILEIU2

    Término da nomeação de Jose Peralta como diretor

    1 páginasTM01
    X2BZD7JS

    Nomeação de Mr Leon Barry Abbitt como diretor

    2 páginasAP01
    X2BZD5KQ

    Término da nomeação de Mark Steven como diretor

    1 páginasTM01
    X2BZD1KY

    Término da nomeação de Louis Vernaus como diretor

    1 páginasTM01
    X265SX41

    Término da nomeação de Maarten Kusters como diretor

    1 páginasTM01
    X25NOTLM

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed mcintosh donald LIMITED\certificate issued on 04/04/13
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name04/04/2013

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15
    change-of-name04/04/2013

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    X25IGK8I

    Declaração anual preparada até 30/09/2012 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    X1KC1VLD

    legacy

    12 páginasMG01s
    S1JEBWGG

    legacy

    9 páginasMG01s
    S1JEBWJ4

    Quem são os diretores de VION SUBCO MD LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Secretário
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director153119640001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretário
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British388530001
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretário
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British138570001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secretário
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secretário
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretário
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BUCHAN, Eric
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    Diretor
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    BritishProcurement Director91024360001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishFinancial Director388530001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Diretor
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    DutchDirector129239540002
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Diretor
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishCompany Director402690001
    DUNCAN, Gordon Scott
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    Diretor
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    BritishProperty Consultant33741760001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director105961550001
    GREEN, Ralph
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    Diretor
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishCommercial Manager56693150001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishAccountant63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Diretor
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutchCeo167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Diretor
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    DutchChief Financial Officer126350570004
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Diretor
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishConsultant515220001
    MCNAUGHTON, Alan John
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    Diretor
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishSales Director44916150002
    MELVIN, John Robertson
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSolicitor134100002
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSolicitor138570001
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Diretor
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    BritishCompany Director338220001
    PERALTA, Jose Juan
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomCanadianManaging Director55989090003
    POCOCK, Patrick William
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    Diretor
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    BritishChartered Accountant36234170001
    PROVAN, James Lyal Clark
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    Diretor
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    BritishEec Affairs Consultant1041290001
    RHIND, Evelyn Kerr
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Diretor
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    BritishCompany Director389060001
    RHIND, John
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Diretor
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    BritishRetired Farmer389050001
    ROEBUCK, Robert Isla
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    Diretor
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    BritishSales Director56693510004
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director111995510001
    SOBEY, Michael John
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    Diretor
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    United KingdomBritishAccountant895550001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Diretor
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director338210001
    STEPHEN, Eric John
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    Diretor
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishFarmer441180002
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director159788300001
    STRACHAN, Wilfred
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishProcurement Officer388540001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Director146206430001

    VION SUBCO MD LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Second ranking security agreement
    Criado em 02/10/2012
    Entregue em 12/10/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 12/10/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 15/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    First ranking security agreement
    Criado em 02/10/2012
    Entregue em 12/10/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 12/10/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 15/01/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 29/05/2007
    Entregue em 13/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/06/2007Registro de uma garantia (410)
    • 13/06/2007Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 15/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 29/05/2007
    Entregue em 13/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/06/2007Registro de uma garantia (410)
    • 13/06/2007Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 15/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Bond & floating charge
    Criado em 07/12/1998
    Entregue em 24/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/12/1998Registro de uma garantia (410)
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 21/09/1998
    Entregue em 06/10/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The meat factory and others,portlethen,kincardineshire.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transações
    • 06/10/1998Registro de uma garantia (410)
    • 15/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 28/07/1998
    Entregue em 14/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transações
    • 14/08/1998Registro de uma garantia (410)
    • 17/08/1998Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 13/06/2007Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 15/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Standard security
    Criado em 10/09/1996
    Entregue em 20/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The meat factory,portlethen and other properties...............see ch paper apart 2 on ch microfiche.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/09/1996Registro de uma garantia (410)
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 01/09/1995
    Entregue em 19/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The meat factory, portlethen and other properties........ See ch microfiche.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transações
    • 19/09/1995Registro de uma garantia (410)
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 28/03/1995
    Entregue em 11/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    See page 2 of doc.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/04/1995Registro de uma garantia (410)
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 17/03/1995
    Entregue em 28/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee of Others
    Transações
    • 28/03/1995Registro de uma garantia (410)
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 18/08/1993
    Entregue em 27/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Obligations contained in missivesdated 23RD april, 5TH, 10TH (2 letters), 12TH, 24TH and 25TH all days of may 1993
    Breve descrição
    (1ST) 3 strips of ground part of the farm and lands of milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire as relative to disposition by mcintosh donald LTD ifo malcolm allan housebuilders LTD dated 30TH july and recorded grs aberdeen 18TH aug 1993. (2ND) 1,840 square metres part of the alford branch railway line in said parish described in disposition by grampian regional council ifo mcintosh donald LTD dated 26TH july and recorded grs aberdeen 4TH nov 1991.
    Pessoas com direito
    • Malcolm Allan Housebuilders Limited
    Transações
    • 27/08/1993Registro de uma garantia (410)
    • 25/08/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 05/04/1991
    Entregue em 15/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The meat factory portlellen kincardinshire.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/04/1991Registro de uma garantia
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 11/05/1988
    Entregue em 24/05/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/05/1988Registro de uma garantia
    • 18/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 25/06/1980
    Entregue em 03/07/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Farms and lands of damhead of minnes, foveran, aberdeenshire cockley, maryculter, kincardineshire milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire hill of minnes, foveran, aberdeenshire mains of badentoy, portlethen, kincardineshire the farming unit of balquharn, cookston, eskywell and the lands of craighead, portlethen, kincardineshire extending in all to one thousand two hundred and seventy acres or thereby.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transações
    • 03/07/1980Registro de uma garantia

    VION SUBCO MD LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    09/04/2017Data prevista de dissolução
    10/04/2015Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0