COMPCO HOLDINGS LIMITED

COMPCO HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOMPCO HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC037323
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COMPCO HOLDINGS PLC08/03/196208/03/1962

    Quais são as últimas contas de COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2022

    Quais são as últimas submissões para COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Término da nomeação de Steven Ross Collins como diretor em 18/09/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Niki Maxine Cole como diretor em 18/09/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Niki Cole como diretor em 30/06/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Terence Shelby Cole como diretor em 30/06/2023

    1 páginasTM01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2022

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2021

    7 páginasAA

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2020

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2019

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2018

    13 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2017

    14 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Richard Jeremy De Barr como secretário em 23/06/2017

    1 páginasTM02

    Satisfação total da garantia 7

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 10

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Diretor
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritish59275730001
    DE BARR, Richard Jeremy
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    Secretário
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    British43885410001
    MCPAKE, Ian Alan Herbert
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Midlothian
    Secretário
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Midlothian
    British1087400003
    RANKEN & REID SSC
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    Secretário
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    36900001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Diretor
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BUTTON, John Martin
    Highclere
    Coin Colin, St. Martin
    GY4 6AQ Guernsey
    Channel Islands
    Diretor
    Highclere
    Coin Colin, St. Martin
    GY4 6AQ Guernsey
    Channel Islands
    British8959490001
    COLE, Niki Maxine
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Diretor
    Level 4 Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritish303564480001
    COLE, Terence Shelby
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    Diretor
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    Diretor
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    EnglandBritish7128850005
    HOWES, Christopher Kingston, Sir
    Westerly House
    IP15 5EL Aldeburgh
    Suffolk
    Diretor
    Westerly House
    IP15 5EL Aldeburgh
    Suffolk
    EnglandBritish84824340001
    JAYE, Andrew Ian
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish10174290002
    LEAVER, Brian Ivan
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    Diretor
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish13082210001
    LEHMANN, Colin Ivor
    25 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Diretor
    25 Totteridge Village
    N20 8PN London
    EnglandBritish43173670002
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Diretor
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritish6639590001
    MYERS, Bernard Ian
    New Court
    St Swithins Lane
    EC4P 4DU London
    Diretor
    New Court
    St Swithins Lane
    EC4P 4DU London
    United KingdomBritish47627350005
    NADLER, John Esmond
    Flat 4 Essex Court
    30 St James Place
    SW1 London
    Diretor
    Flat 4 Essex Court
    30 St James Place
    SW1 London
    British1791570001
    NADLER, Robert Arthur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    Diretor
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    United KingdomBritish33752790002
    PICKFORD, David Michael
    Elm Tree Farm
    Mersham
    TN25 7HS Ashford
    Kent
    Diretor
    Elm Tree Farm
    Mersham
    TN25 7HS Ashford
    Kent
    British64475900002
    ROSS, Nigel Keith
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Diretor
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    United KingdomBritish47878830001
    RUBENS, Kenneth David
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Diretor
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    United KingdomBritish35531750001
    WOLFSON OF SUNNINGDALE, David, Lord
    1 Portobello Studios
    Haydens Place
    W11 1LY London
    Diretor
    1 Portobello Studios
    Haydens Place
    W11 1LY London
    EnglandBritish92063640001

    Quem são as pessoas com controle significativo de COMPCO HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    City & General Securities Ltd
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    06/04/2016
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    COMPCO HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of amendment and confirmation
    Criado em 26/03/2012
    Entregue em 10/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/04/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of confirmation
    Criado em 26/03/2012
    Entregue em 10/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time while the floating charge is in force comprised in the property and undertaking of the chargor.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/04/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Bond & floating charge
    Criado em 26/03/2012
    Entregue em 10/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/04/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 10/04/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Debenture
    Criado em 26/03/2012
    Entregue em 10/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/04/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 05/09/2003
    Entregue em 23/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due under the charge, each of the facility agreements and each of the other finance documents
    Breve descrição
    First legal mortgage, first fixed charge and floating charge over assets.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 23/09/2003Registro de uma garantia (410)
    • 24/09/2003Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 06/09/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Bond & floating charge
    Criado em 04/09/2003
    Entregue em 23/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due under each finance document
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 23/09/2003Registro de uma garantia (410)
    • 24/09/2003Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 06/09/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 10/04/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 12/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Legal charge
    Criado em 10/12/1999
    Entregue em 16/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Property at madeira drive, brighton.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/12/1999Registro de uma garantia (410)
    • 29/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Third party deed of charge over shareholders' loans
    Criado em 19/10/1995
    Entregue em 06/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All the company's present and future rights, title and interest in and to the sum of £350,000 together with any interest arising from a loan in connection with the purchase of property at 9 bridge street, newport.
    Pessoas com direito
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transações
    • 06/11/1995Registro de uma garantia (410)
    • 29/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Guarantee & floating charge
    Criado em 19/09/1967
    Entregue em 25/09/1967
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due under the said guarantee by the company to the chargee
    Breve descrição
    The sum of £80,000 deposited by the company with the chargee & all moneys now or hereafter standing to the credit of the company's deposit accounts with the chargee up to the sum of £80,000.
    Pessoas com direito
    • British and French Bank LTD
    Transações
    • 25/09/1967Registro de uma garantia
    • 22/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0