GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC039207
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BETT HOMES (NORTH WEST) LIMITED 05/03/200305/03/2003
    BETT HOMES (NORTHERN) LIMITED06/10/199506/10/1995
    BETT DEVELOPMENTS LIMITED16/05/198616/05/1986
    CHARLES E. SPALDING (PROPERTIES) LIMITED03/09/196303/09/1963

    Quais são as últimas contas de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 11/12/2015

    • Capital: GBP 2.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Glyn David Mabey em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG para Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 12/03/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/03/2015

    Estado do capital em 12/03/2015

    • Capital: GBP 12,016,000
    SH01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 20

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 18

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 17

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 16

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 15

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 12

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 10

    4 páginasMR04

    Quem são os diretores de GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secretário
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809270001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    MABEY, Glyn David
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesBritish100945610001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secretário
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Diretor
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Diretor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75879360004
    BALL, Malcolm
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Diretor
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Great BritainBritish107732120001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Diretor
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BURTON, Christopher Julian
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    Diretor
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    British71961290002
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Diretor
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CALDWELL, Denise Elsie
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    Diretor
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    British122926060001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COLLS, Andrew John
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish61370150001
    CORRIN, Brian Stanley
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    Diretor
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish110416140001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Diretor
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GORE, Derek Cyril
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    Diretor
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    British92043160001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Diretor
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    GRIFFIN, Stephen Barry
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    Diretor
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    British66519990002
    HANDYSIDE, Mark
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    British56712320001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    HIRST, Stephen Jeremy
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    Diretor
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    United KingdomBritish95787000001
    KELLY, Richard Ian
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    Diretor
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    United KingdomBritish157317280001
    LANCASTER, Michaela Dawn
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    Diretor
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish79770560001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LAW, Ronald Douglas
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    Diretor
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    British67443350001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Diretor
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 16/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 24/02/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 24/02/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (MG05s)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Shares pledge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    2 ordinary shares in gladedale (dundee) limited.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 24/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02s)
    Shares pledge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    1,000 ordinary shares in gladedale (central scotland) limited.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 01/09/2009
    Entregue em 15/09/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/09/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Share pledge
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 14/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Entire right, title and interest (present and future) to the shares.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 14/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 08/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/01/2009Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Floating charge
    Criado em 21/05/2003
    Entregue em 03/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/06/2003Registro de uma garantia (410)
    • 18/09/2009Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 16/07/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Legal charge
    Criado em 18/06/1990
    Entregue em 25/06/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Ironbank car park site, east side thorpe road staines sy 566260.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 25/06/1990Registro de uma garantia
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 16/01/1990
    Entregue em 29/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Freehold property known as tudor lodge, king harry st, hemal hempstead, hertfordshire.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/01/1990Registro de uma garantia
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 16/05/1989
    Entregue em 18/05/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Plot 8, south partway business park, old sarom, laverstock, wiltshire.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 18/05/1989Registro de uma garantia
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 23/03/1989
    Entregue em 10/04/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £100,000
    Breve descrição
    120 west campbell street, glasgow.
    Pessoas com direito
    • Birnam Securities (Glasgow) Limited
    Transações
    • 10/04/1989Registro de uma garantia
    • 30/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 30/12/1988
    Entregue em 10/01/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Land north west side crabtree road thorpe part sy 535529 sy 485155 sy 489268.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/01/1989Registro de uma garantia
    Standard security
    Criado em 08/12/1988
    Entregue em 22/12/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Land at crabtree road, thorpe nr. Staines, middlesex.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 22/12/1988Registro de uma garantia
    Standard security
    Criado em 22/07/1987
    Entregue em 04/08/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Area of ground in the city of glasgow and county of the barony and regality of glasgow.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/08/1987Registro de uma garantia
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Standard security
    Criado em 02/02/1987
    Entregue em 06/02/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    1,029.59 square metres in kilmarnock ayrshire.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 06/02/1987Registro de uma garantia
    Letter of offset
    Criado em 10/04/1984
    Entregue em 24/04/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and or others
    Breve descrição
    Balances at credit of any account held by the bank of scotland.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/04/1984Registro de uma garantia
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0