RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC040149 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street G2 1BP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| AYRSHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | 02/04/1964 | 02/04/1964 |
Quais são as últimas contas de RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2022 |
Quais são as últimas submissões para RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Cessação de Lloyds Chemists Limited como pessoa com controlo significativo em 31/08/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland para Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP em 18/09/2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Notificação de Dunamis Mind Accelerator Limited como pessoa com controlo significativo em 31/08/2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Graham Wiseman como diretor em 31/08/2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nomeação de Thorsten Sprank como diretor em 31/08/2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed ayrshire pharmaceuticals LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Estado do capital em 15/08/2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/04/2023 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Wendy Margaret Hall como diretor em 09/09/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Nichola Louise Legg como secretário em 09/09/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Memorando e estatutos | 33 páginas | MA | ||||||||||||||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||||||||||
Alteração do nome ou designação da classe de ações | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||||||||||
Nomeação de Graham Wiseman como diretor em 07/09/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Christian Keen como diretor em 18/05/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Quem são os diretores de RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Diretor | Crays Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | 203900280002 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secretário | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Secretário | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Secretário | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| GILMOUR, David Strachan | Secretário | 5 Laigh Mount KA7 4QS Ayr South Ayrshire Scotland | British | 52130850001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Secretário | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Secretário | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | 163214890001 | |||||||
| NASH, Andrew | Secretário | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| RAINEY, Gary | Secretário | 95 Greenacres KA22 7PR Ardrossan Ayrshire | British | 3535890001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Secretário | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| SMERDON, Peter | Secretário | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| BEER, Thorsten | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| COCKBURN, Henry James Kemp | Diretor | 16 Dalzell Avenue ML1 2BX Motherwell Lanarkshire | British | 504660001 | ||||||
| FELLOWS, Jonathan | Diretor | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| GILBERT, George Andrew | Diretor | Tredawn White Plains KA7 4 Ayr | British | 469190001 | ||||||
| HALL, Wendy Margaret | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Germany | German | 238936580003 | |||||
| HOOD, John | Diretor | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| JOHNSTONE, Ian James | Diretor | 47 Adele Street ML1 2QE Motherwell Lanarkshire | Scotland | British | 58656120002 | |||||
| KEEN, Christian | Diretor | Hampden Park Industrial Estate G42 0PH Glasgow 204 Polmadie Road Scotland | England | British | 54544790004 | |||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Diretor | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| LLOYD, Allen John | Diretor | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Diretor | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| MCCONNELL, Walter Scott | Diretor | Braehead Of Priestgill ML10 6PS Strathaven | British | 469160001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Diretor | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Diretor | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| PRINGLE, John Stock | Diretor | Upper Carbarns Farm Netherton ML2 0RW Wishaw | British | 355710003 | ||||||
| RILLIE, George Davidson | Diretor | 11 Arnprior Place Alloway KA7 4PT Ayr Ayrshire | British | 88210002 | ||||||
| SHEPHERD, William | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Diretor | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| STEELE, Richard John | Diretor | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | 1415570001 | |||||
| TAYLOR, Andrew James | Diretor | 7 Milton Gardens Calderbraes G71 6EB Uddingston | British | 29348070001 | ||||||
| TURNER, Richard Gill | Diretor | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | 51796560002 | ||||||
| VIZARD, Ronald Charles, Harold | Diretor | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 122881190001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunamis Mind Accelerator Limited | 31/08/2023 | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Lloyds Chemists Limited | 06/04/2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
RUBY DCO TWENTY ONE LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Criado em 05/02/1990 Entregue em 12/02/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição 1.39 acres bounded by townholme and harriet road, kilmarnock, ayrshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 16/01/1973 Entregue em 22/01/1973 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0