KUC PROPERTIES LIMITED

KUC PROPERTIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKUC PROPERTIES LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC044073
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KUC PROPERTIES LIMITED?

    • Administração de imóveis por conta de terceiros (68320) / Atividades imobiliárias

    Onde fica KUC PROPERTIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Rbs Gogarburn
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KUC PROPERTIES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RAVENSTONE SECURITIES (HOLDINGS) LIMITED28/11/196628/11/1966

    Quais são as últimas contas de KUC PROPERTIES LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2025
    Próximas contas vencem em30/09/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2024

    Qual é o status da última declaração de confirmação para KUC PROPERTIES LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até15/01/2026
    Próxima declaração de confirmação vence29/01/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até15/01/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para KUC PROPERTIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas anuais preparadas até 31/12/2024

    18 páginasAA

    Nomeação de Fiona Katherine Cummins como diretor em 19/05/2025

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de James Mccubbin Rowney como diretor em 19/05/2025

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/01/2025 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2023

    18 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2024 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2022

    20 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2023 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2021

    19 páginasAA

    Nomeação de Mr Howard Nicholas Ferguson Martin como diretor em 19/07/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mark Brandwood como diretor em 14/06/2022

    1 páginasTM01

    Memorando e estatutos

    34 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Declaração de confirmação apresentada em 17/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2020

    19 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mark Brandwood em 07/09/2021

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Natwest Group Secretarial Services Limited em 03/08/2020

    1 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Mr James Mccubbin Rowney em 27/08/2021

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de National Westminster Bank Plc como pessoa com controlo significativo em 14/12/2018

    2 páginasPSC05

    Contas anuais preparadas até 31/12/2019

    20 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 16/02/2021 com atualizações

    5 páginasCS01

    Detalhes do secretário alterados para Rbs Secretarial Services Limited em 16/09/2020

    1 páginasCH04

    Endereço do domicílio registado alterado de 24/25 st Andrew Square Edinburgh EH2 1AF para Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road Edinburgh EH12 1HQ em 03/08/2020

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 17/02/2020 com atualizações

    5 páginasCS01

    Quem são os diretores de KUC PROPERTIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secretário
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registroSC269847
    169073830002
    CUMMINS, Fiona Katherine
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Diretor
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    EnglandBritishBank Official204021610001
    MARTIN, Howard Nicholas Ferguson
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    United Kingdom
    Diretor
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    United Kingdom
    United KingdomBritishBank Official297622630001
    CRAIG, Mark
    2f2, 7 Polwarth Crescent
    EH11 1HP Edinburgh
    Secretário
    2f2, 7 Polwarth Crescent
    EH11 1HP Edinburgh
    BritishBank Official63130650003
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Secretário
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    FOSTER, Kennedy Campbell
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    Secretário
    4 Deacons Court
    EH49 6BT Linlithgow
    West Lothian
    British70070530001
    GREENE, John Henderson
    7 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    Secretário
    7 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    British71320001
    MACGILLIVRAY, Shirley Margaret
    33 Badger Walk
    EH52 5TW Broxburn
    West Lothian
    Secretário
    33 Badger Walk
    EH52 5TW Broxburn
    West Lothian
    British40027890002
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Secretário
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    SMITH, Carolyn
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    Secretário
    9 Bedford Court
    Mowbray Road Upper Norwood
    SE19 2RW London
    British68031820001
    BEATTIE, Ian David
    21 Calder Avenue
    KA10 7JT Troon
    Ayrshire
    Diretor
    21 Calder Avenue
    KA10 7JT Troon
    Ayrshire
    BritishChartered Accountant79483650001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BRANDWOOD, Mark
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Diretor
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    EnglandBritishBank Official204418370002
    BUCHAN, Alison
    13 Fontstane Road
    Monifieth
    DD5 4JX Dundee
    Angus
    Diretor
    13 Fontstane Road
    Monifieth
    DD5 4JX Dundee
    Angus
    ScotlandBritishBank Official269514710001
    CAMERON, John
    Newburn Lodge 22 Sidegate
    EH41 4BZ Haddington
    East Lothian
    Diretor
    Newburn Lodge 22 Sidegate
    EH41 4BZ Haddington
    East Lothian
    BritishCorporate Director19251450001
    CARRARO, Philip Andrew
    70 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    Diretor
    70 Onslow Gardens
    SW7 3QD London
    United States CitizenBanker64702980001
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Diretor
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    BritishDirector38897330001
    CHRISPIN, Simon Jonathan
    41 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    41 Claygate Avenue
    AL5 2HE Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant62029940002
    CHRISTIE, Ridi Euridiki Stakis
    45 Sherbrooke Avenue
    Pollokshields
    G41 4SD Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    45 Sherbrooke Avenue
    Pollokshields
    G41 4SD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishConsultant277740001
    CONNELL, Alan
    22 Rowan Road
    G41 5BZ Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    22 Rowan Road
    G41 5BZ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishFinancial Director2804330001
    CULLINAN, Rory Malcolm
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    Diretor
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    EnglandBritishBank Official149327390001
    GREENE, John Henderson
    7 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    Diretor
    7 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    BritishSolicitor71320001
    JAY, Ian Scott
    L'Ancora 1 Stable Road
    Milngavie
    G62 7LY Glasgow
    Diretor
    L'Ancora 1 Stable Road
    Milngavie
    G62 7LY Glasgow
    BritishChartered Surveyor277320001
    KEARNEY, Douglas Richard
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    Diretor
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    ScotlandBritishChartered Accountants93762430001
    LAMBERT, Mark Andrew
    1 Oakview Cottages
    Upper Green Road Shipbourne
    TN11 9PQ Tonbridge
    Kent
    Diretor
    1 Oakview Cottages
    Upper Green Road Shipbourne
    TN11 9PQ Tonbridge
    Kent
    BritishBank Official75051270001
    LINCOLN, Howard David
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    Diretor
    EC2M 4RB London,
    280 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official202721190001
    MAIR, Angus James Murray, Mr.
    1 Belford Park
    EH4 3DP Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    1 Belford Park
    EH4 3DP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official85930020003
    NASH, Peter Edward
    Weavers Cottage
    Gydynap Lane
    Amberley
    Glocs
    Diretor
    Weavers Cottage
    Gydynap Lane
    Amberley
    Glocs
    BritishChartered Surveyor14953330001
    NICOL, Ian Fraser
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Diretor
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official154118870001
    ROWNEY, James Mccubbin
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Diretor
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    ScotlandBritishBank Official59551350002
    SACH, Derek Stephen
    Hattingley House
    Hattingley Road, Medstead
    GU34 5NQ Alton
    Hampshire
    Diretor
    Hattingley House
    Hattingley Road, Medstead
    GU34 5NQ Alton
    Hampshire
    United KingdomBritishBanker646390004
    SACH, Derek Stephen
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    Diretor
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    BritishBanker646390001
    SANDERS, Stuart Currie
    25 Greenbank Loan
    EH10 5SJ Edinburgh
    Diretor
    25 Greenbank Loan
    EH10 5SJ Edinburgh
    ScotlandBritishBank Official77340230001
    SHEAVILLS, Ernest Michael
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    Diretor
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    BritishBank Official34817880001
    SPEIRS, Robert
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    Diretor
    17 Kings Crescent
    G84 7RB Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishGroup Finance Director2592770003

    Quem são as pessoas com controle significativo de KUC PROPERTIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    01/01/2017
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUk Companies Acts
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00929027
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0