QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED

QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaQUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC054465
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    • Comércio grossista de vinho, cerveja, bebidas espirituosas e outras bebidas alcoólicas (46342) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MARBLEHEAD BRAND DEVELOPMENT LIMITED15/03/199615/03/1996
    MARBLEHEAD TRADING LIMITED13/02/198713/02/1987
    RIVINVEND LIMITED09/11/197309/11/1973

    Quais são as últimas contas de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2024
    Próximas contas vencem em31/12/2024
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até12/01/2025
    Próxima declaração de confirmação vence26/01/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até12/01/2024
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Alex Pollard como diretor em 17/09/2024

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland para C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ em 11/04/2024

    3 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 03/04/2024

    LRESSP

    Satisfação total da garantia SC0544650007

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC0544650009

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia SC0544650008

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 12/01/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2023

    10 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland para 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY em 02/11/2023

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Quartermile One, 15 Lauriston Place Edinburgh EH3 9EP Scotland para 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY em 02/11/2023

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 12/01/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022

    10 páginasAA

    Término da nomeação de Warren Michael Scott como diretor em 26/07/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de James David Lousada como diretor em 08/07/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 12/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2021

    25 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2020

    29 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 31/03/2019

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Registo da garantia SC0544650009, criada em 17/12/2020

    122 páginasMR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr James David Lousada em 19/11/2020

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Alex Pollard como diretor em 07/07/2020

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr James Lousada como diretor em 07/10/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Michael Clifford como secretário em 31/03/2020

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VISONE, Vincenzo
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Diretor
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    MonacoItalian152578310001
    BOOTH, Esther
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Secretário
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    238800260001
    BROWN, Sophie
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    United Kingdom
    Secretário
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    United Kingdom
    185803300001
    CLIFFORD, Michael
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Secretário
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    245504730001
    DORMAN, Arthur Brian
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    Secretário
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    British752770003
    HENDERSON, Samuel Joseph
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British461450001
    LISTER, Steven Geoffrey
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Secretário
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    215481910001
    LOVE, Robert
    48 Grenville Drive
    Cambuslang
    G72 8DP Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    48 Grenville Drive
    Cambuslang
    G72 8DP Glasgow
    Lanarkshire
    British1104220001
    ROBERTSON, Bryan Carey
    16 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5HR Glasgow
    Secretário
    16 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5HR Glasgow
    British60602380002
    ROBERTSON, Carey
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Secretário
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    British146903990001
    STEEL, Robin Gray
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    Secretário
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    British79076290001
    URE, Julie East
    17 North Crescent Road
    KA22 8NA Ardrossan
    Ayrshire
    Secretário
    17 North Crescent Road
    KA22 8NA Ardrossan
    Ayrshire
    British81670520003
    AGNEW, Richard Alexander
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritish461440004
    AMNER, Kenneth Ian Mcdonald
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    British462540001
    AMNER, Kenneth Ian Mcdonald
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    5 Kirkdene Grove
    Newton Mearns
    G77 5RW Glasgow
    Lanarkshire
    British462540001
    BROWN, Sophie Nina
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish184987420001
    DORMAN, Arthur Brian
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    Diretor
    Shawhill House
    Galston Road Hurlford
    KA1 5H2 Kilmarnock
    Strathclyde
    British752770003
    GRAHAM, Heather Claire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish27043920005
    HENDERSON, Samuel Joseph
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    105 Ormonde Avenue
    Netherlee
    G44 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British461450001
    HENDRY, James Williamson
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    Diretor
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    British72259690001
    HENDRY, James Williamson
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    Diretor
    Timaru 37 Maclachlan Avenue
    FK6 5HF Denny
    Stirlingshire
    British72259690001
    KEITH, Richard Maxwell
    14 Russell Place
    EH5 3HH Edinburgh
    Scotland
    Diretor
    14 Russell Place
    EH5 3HH Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish46747460001
    LISTER, Steven Geoffrey
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    EnglandBritish215478530001
    LOUSADA, James David
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Diretor
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    EnglandBritish152222000001
    MORGAN, John White
    21 Claremont Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4EE Stirling
    Stirlingshire
    Diretor
    21 Claremont Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4EE Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish35561700001
    POLLARD, Alex
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Diretor
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    EnglandBritish275119170001
    SALMON, Mike
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish180282760001
    SCOTT, Warren Michael
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    Diretor
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Quartermile One,
    Scotland
    EnglandBritish151869960001
    STEEL, Robin Gray
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    Diretor
    48 Viewpark Drive
    Burnside
    G73 3QD Glasgow
    British79076290001
    STEWARD, David
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Diretor
    17-27 Station Road
    Milngavie
    G62 8PG Glasgow
    East Dunbartonshire
    United KingdomBritish199652170001
    STEWARD, David
    42 Church Street
    Coggeshall
    CM7 5JY Braintree
    Essex
    Diretor
    42 Church Street
    Coggeshall
    CM7 5JY Braintree
    Essex
    British47647120003
    WYKES, Emma Claire
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    Diretor
    1 Aurora Avenue
    Queens Quay
    G81 1BF Clydebank, Glasgow
    Suite 1/4 Titan Enterprise
    Dunbartonshire
    Scotland
    United KingdomBritish179739820001

    Quem são as pessoas com controle significativo de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Quintessential Spirits Uk Limited
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    England
    06/04/2016
    Clayton Road
    Birchwood
    WA3 6PH Warrington
    Distribution Point, Melbury Park
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalThe Companies Act 2006
    Local de registroEngland & Wales
    Número de registro7723026
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 17/12/2020
    Entregue em 22/12/2020
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Property located at distribution point, melbury court, risley, warrington registered at the land registry with title number CH561943. UK trademark with application number UK00002428193 and registration number UK00002428193. For further details of land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transações
    • 22/12/2020Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/03/2024Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 03/12/2018
    Entregue em 05/12/2018
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transações
    • 05/12/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/03/2024Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/08/2018
    Entregue em 01/08/2018
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transações
    • 01/08/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/03/2024Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 10/06/2015
    Entregue em 12/06/2015
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 12/06/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 10/03/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Floating charge
    Criado em 27/04/2012
    Entregue em 05/05/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 05/05/2012Registro de uma garantia (MG01s)
    • 12/05/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 10/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    • Possui alterações na ordem: Sim
    Standard security
    Criado em 10/04/1989
    Entregue em 18/04/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    17 cloberfield milngavie dmb 16893.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 18/04/1989Registro de uma garantia
    • 13/07/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Letter of agreement
    Criado em 19/07/1988
    Entregue em 03/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All sums invested with bank or bid deposit acc. No. 91003070 and interest accrued thereon.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 03/08/1988Registro de uma garantia
    Floating charge
    Criado em 26/09/1978
    Entregue em 06/10/1978
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 06/10/1978Registro de uma garantia
    • 12/05/2012Alteração a uma garantia flutuante (466 Scot)
    • 13/07/2018Satisfação de uma garantia (MR04)

    QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    03/04/2024Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0