BRITSHIP TWO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBRITSHIP TWO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC055006
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BRITSHIP TWO LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica BRITSHIP TWO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BLUE STAR LINE MARINE LIMITED18/09/199618/09/1996
    STAR OFFSHORE SERVICES MARINE LIMITED07/02/197407/02/1974

    Quais são as últimas contas de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2008

    Quais são as últimas submissões para BRITSHIP TWO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Ata da reunião final da liquidação voluntária

    3 páginas4.26(Scot)

    Detalhes do secretário alterados para John Kilby em 22/12/2009

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para John Kilby em 22/12/2009

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ em 24/12/2009

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/11/2009

    LRESSP

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed blue star line marine LIMITED\certificate issued on 21/07/09
    2 páginasCERTNM

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 31/12/2008

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 31/12/2007

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Contas preparadas até 31/12/2006

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Secretário
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    British76247880001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Diretor
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Diretor
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    EnglandBritish76247880001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secretário
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Secretário
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Secretário
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secretário
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Diretor
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BRYCE, John Alexander
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish69880420001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Diretor
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    COLLINS, John Alexander, Sir
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    Diretor
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    British53032980001
    COOPER, Robert Hamilton
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    Diretor
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish11632250002
    CORK, Barry Philip Arthur
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    Diretor
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    British555660003
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    DAWS, Christopher
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    Diretor
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    British555670001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Diretor
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Diretor
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Diretor
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Diretor
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Diretor
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Diretor
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Diretor
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SPENCER-PAYNE, Christopher David
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    British66395410001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Diretor
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WOODS, Robert Barclay
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    Diretor
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    EnglandBritish154397820001

    BRITSHIP TWO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    General assignment
    Criado em 08/12/1997
    Entregue em 29/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All rights title and interest in the assigned property mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Pessoas com direito
    • Credit Agricole Indosuez
    Transações
    • 29/12/1997Registro de uma garantia (410)
    • 07/09/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenant
    Criado em 08/12/1997
    Entregue em 29/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All rights, title and interest to an in th mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Pessoas com direito
    • Credit Agricole Indosuez
    Transações
    • 29/12/1997Registro de uma garantia (410)
    • 07/09/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Ship mortgage
    Criado em 08/12/1997
    Entregue em 29/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in the mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Pessoas com direito
    • Credit Agricole Indosuez
    Transações
    • 29/12/1997Registro de uma garantia (410)
    • 07/09/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    General assignment
    Criado em 10/01/1996
    Entregue em 31/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Earnings and requisition compensation of the M.V. "sydney star".
    Pessoas com direito
    • Banque Indosuez
    Transações
    • 31/01/1996Registro de uma garantia (410)
    • 19/02/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenant
    Criado em 10/01/1996
    Entregue em 25/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in M.V. "sydney star"....see ch microfiche.
    Pessoas com direito
    • Banque Indosuez
    Transações
    • 25/01/1996Registro de uma garantia (410)
    • 19/02/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    First priority bahamas stat.mortgage
    Criado em 10/01/1996
    Entregue em 25/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in M.V. "sydney star",nassau 343036 and boats,guns,ammunition,small arms and appertunances.
    Pessoas com direito
    • Banque Indosuez
    Transações
    • 25/01/1996Registro de uma garantia (410)
    • 19/02/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Assignment agreement
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descrição
    The earnings....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 09/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenants
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descrição
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 09/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Second deed of covenants
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Second priority bahamian ship mortgage
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenants
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenants
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 14/03/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Second assignment of earnings
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Assignment of earnings
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Assignment of earnings
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Assigned monies"........ See ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 14/03/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451.
    Pessoas com direito
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 14/03/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Criado em 20/11/1995
    Entregue em 07/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/12/1995Registro de uma garantia (410)
    • 09/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    First priority statutory mortgage
    Criado em 30/04/1992
    Entregue em 07/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Pessoas com direito
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transações
    • 07/05/1992Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Second priority statutory mortgage
    Criado em 30/04/1992
    Entregue em 07/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/05/1992Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenant
    Criado em 29/04/1992
    Entregue em 07/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £7,400,000
    Breve descrição
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus".
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/05/1992Registro de uma garantia (410)
    • 20/05/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Delivery order
    Criado em 22/03/1991
    Entregue em 28/03/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All materials, engines and machinery of yard no. 603.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/1991Registro de uma garantia
    • 14/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    3RD priority mortgage
    Criado em 22/03/1991
    Entregue em 28/03/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in "star altair" official no. 701173.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/1991Registro de uma garantia
    • 14/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenant
    Criado em 22/03/1991
    Entregue em 28/03/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in M.V. "star altair" official no 701173.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/1991Registro de uma garantia
    • 14/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Deed of covenant
    Criado em 22/03/1991
    Entregue em 28/03/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64/64TH shares in M.V. "star capella" official no 701153.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/1991Registro de uma garantia
    • 14/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    BRITSHIP TWO LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    27/07/2010Data de dissolução
    30/11/2009Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0