THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC058099 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
- Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (09100) / Exploração de minas e pedreiras
Onde fica THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum Aberdeenshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| STOLT-NIELSEN SEAWAY (U.K.) LIMITED | 08/03/1990 | 08/03/1990 |
| STOLT-NIELSEN SEAWAY CONTRACTING LIMITED | 21/06/1985 | 21/06/1985 |
| STOLT-NEILSEN SEAWAY LIMITED | 02/07/1975 | 02/07/1975 |
Quais são as últimas contas de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2015 |
Quais são as últimas submissões para THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Nomeação de Mr James Henry John Marsh como secretário em 03/07/2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Hoggan como secretário em 03/07/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/09/2016 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/09/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 08/09/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Martin Graham Marsh em 01/09/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Michael John Howarth como diretor em 13/08/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Giovanni Corbetta como diretor em 05/08/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia SC0580990012 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 11 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 123 Ashgrove Road West Aberdeen AB16 5FA para C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows Oldmeldrum Aberdeenshire AB51 0GC em 12/02/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Michael Hoggan como secretário em 09/02/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de David Russell Smith como diretor em 09/02/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Russell Smith como secretário em 09/02/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Martin Graham Marsh como diretor em 09/02/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael John Howarth como diretor em 09/02/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 10 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 08/09/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Alterações a uma garantia flutuante | 11 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
Quem são os diretores de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH, James Henry John | Secretário | Michaelson Road LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria United Kingdom | 235026530001 | |||||||
| CORBETTA, Giovanni | Diretor | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | Scotland | British | 160476180001 | |||||
| MARSH, Martin Graham | Diretor | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194923760001 | |||||
| HOGGAN, Michael | Secretário | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | 194965170001 | |||||||
| SMITH, David Russell | Secretário | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | British | 20205140001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secretário | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| STOLT OFFSHORE M.S. LIMITED | Secretário | Bucksburn House Howes Road AB16 7QU Aberdeen Aberdeenshire | 74739410001 | |||||||
| ANDERSEN, Ole Christian | Diretor | 47 Marischal Street AB1 2AB Aberdeen | Norwegian | 1300200003 | ||||||
| ANDERSON, Ole Christian | Diretor | 33 Stenderveien 5542 Karsmund Haugesund | British | 1300200001 | ||||||
| BRANNAN, Thomas | Diretor | Cluniter Road Innellan PA23 7SA Dunoon 3 Calderwood | Scotland | British | 140573350001 | |||||
| BRUNNEN, Jeremy Alan | Diretor | 6 Clarence Lodge Middle Hill TW20 0NW Egham Surrey | British | 44706880003 | ||||||
| CHABAS, Bruno Yves Raymond | Diretor | 8 Western Road RG9 1JL Henley On Thames | French | 66271250006 | ||||||
| FRIKSTAD, Paul Arild | Diretor | 3a Rubislaw Don North AB15 4AL Aberdeen | Norwegian | 86298910001 | ||||||
| HIRST, Terence John | Diretor | 73 Kings Gate AB2 6BN Aberdeen Grampian Scotland | British | 39503560001 | ||||||
| HOWARTH, Michael John | Diretor | 123 Ashgrove Road West AB16 5FA Aberdeen National Hyperbaric Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 172532620001 | |||||
| JOHN, Michael Dendle | Diretor | Dundas Yews EH34 5DS Pencaitland | British | 641280001 | ||||||
| LIE, Kaare Johannes | Diretor | Fiolvegen 1 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336280001 | ||||||
| MACKIE, Grahame John Sinclair | Diretor | 35 Hammersmith Road AB1 6NA Aberdeen Aberdeenshire | British | 676720001 | ||||||
| MELING, Jan Fredrik | Diretor | Naumdoelaveien 18 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336290001 | ||||||
| MIKAELSEN, Oeyvind | Diretor | Ragnh Ildsgate 48 4044 Hafrsejord Norway | Norwegian | 91267430001 | ||||||
| OAKLEY, Stuart David | Diretor | Castleton House 15 The Chanonry AB24 1RP Aberdeen Aberdeenshire Scotland | British | 38261820001 | ||||||
| SKOUVEROE, Jan Frithjof | Diretor | Lillevannsveien 12c FOREIGN 0390 Oslo 3 Norway | Norwegian | 25049690001 | ||||||
| SMITH, David Russell | Diretor | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 20205140001 | |||||
| SVENSON, Einar Wold | Diretor | 3 Haraldskroken 4041 Hafrsfjord | British | 1396780001 | ||||||
| VOSSIER, Bernard Lucien | Diretor | Bede House Court 54 Don Street AB2 1UU Aberdeen | French | 44196670001 | ||||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Diretor | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 | |||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Diretor | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Safety Management Limited | 06/04/2016 | Oldmeldrum 4 AB51 0DG Inverurie Fisher Offshore Westbank Park Scotland | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 10/06/2014 Entregue em 19/06/2014 | Totalmente satisfeita | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 14/12/2004 Entregue em 17/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Tenants interest in 2.9 acres at 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 02/12/2004 Entregue em 11/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 15/05/1992 Entregue em 27/05/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Leasehold interest in 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 15/05/1992 Entregue em 27/05/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Area of ground extending to 2.9 acres or thereby lying to the south-east of ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 21/01/1991 Entregue em 04/02/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 24/08/1990 Entregue em 29/08/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Standard security | Criado em 16/07/1990 Entregue em 27/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 29/05/1990 Entregue em 06/06/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 30/03/1987 Entregue em 06/04/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The whole assets of the company. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Letter of offset | Criado em 19/03/1987 Entregue em 27/03/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due by seaway technology and another | |
Breve descrição Balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of stolt-nielsen seaway contracting limited. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 19/03/1987 Entregue em 27/03/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The whole assets of the company. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0