IAN SKELLY GROUP LIMITED

IAN SKELLY GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaIAN SKELLY GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC062560
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP
    302 St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 27/07/2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Término da nomeação de Matthew Bishop como diretor em 01/01/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David John Muir como diretor em 01/01/2019

    2 páginasAP01

    legacy

    44 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    legacy

    51 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Quem são os diretores de IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175736740001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149304780001
    MACNAUGHTON, Elspeth Violet
    50 Brownside Road
    Cambuslang
    G72 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    50 Brownside Road
    Cambuslang
    G72 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    British572930001
    MAHAFFEY, Matthew Ian
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    Secretário
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    British507940001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Secretário
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Secretário
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secretário
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ANDERSON, James Michael
    43 Kingswell
    NE61 2TY Morpeth
    Northumberland
    Diretor
    43 Kingswell
    NE61 2TY Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishAccountant11487420001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDev Dir20102900001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDevelopment Director20102900001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishDirector Overseas Op38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director206755450002
    BROADFOOT, Anthony
    Cairn Skye Fram
    North Rigton
    Leeds 17
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    Cairn Skye Fram
    North Rigton
    Leeds 17
    West Yorkshire
    England
    BritishPersonnel Executive38918730001
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCa1188140001
    COXON, Jeffrey Lance
    Whitehill Hall Gardens
    DH2 2NE Chester Le Street
    2
    Co Durham
    United Kingdom
    Diretor
    Whitehill Hall Gardens
    DH2 2NE Chester Le Street
    2
    Co Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritishManager135123710001
    HEALEY, Derek John
    5 Tudor Court
    Prince Of Wales Mansions
    HG1 1JB Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    5 Tudor Court
    Prince Of Wales Mansions
    HG1 1JB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDev.Dir.46399230001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director123285980005
    HOPE, John Alexander
    Riverside,5 School Brae
    EH4 6JN Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    Riverside,5 School Brae
    EH4 6JN Edinburgh
    Midlothian
    BritishFinancial Director71318590002
    HOUSTON, David Oliver
    3 Eden Park
    Castlepark Bothwell
    G71 3NW Glasgow
    Diretor
    3 Eden Park
    Castlepark Bothwell
    G71 3NW Glasgow
    BritishFinancial Director75910100001
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Diretor
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    BritishFinance Director75730290003
    JOHNSTON, Bruce William Mclaren
    1 Douglas Road
    PH10 6TR Blairgowrie
    Perthshire
    Diretor
    1 Douglas Road
    PH10 6TR Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishNon Executive118976980001
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector12785600004
    MACLAREN, Niall Craig
    Oak House Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Oak House Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishManager32232190002
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary149294820002
    O'DONNELL, Joseph Peter
    5 Brodie Park Avenue
    PA2 6JH Paisley
    Renfrewshire
    Diretor
    5 Brodie Park Avenue
    PA2 6JH Paisley
    Renfrewshire
    BritishOperations Director18421870001
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Diretor
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Diretor
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    BritishCompany Director22325820001
    SKELLY, Ian Barr
    Leewood House
    ML11 9JA Lanark
    Diretor
    Leewood House
    ML11 9JA Lanark
    United KingdomBritishCompany Chairman9845580001
    SKELLY, Margaret Richmond
    Leewood House
    ML11 9JA
    Lanarkshire
    Diretor
    Leewood House
    ML11 9JA
    Lanarkshire
    BritishCompany Director548730001
    STUART, John Morris
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director507950001
    TAYLOR, Phillip
    63 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Diretor
    63 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    BritishCompany Director83887910001
    THOMSON, George Buchanan
    Kingswood 26 Waverley Avenue
    G84 7JU Helensburgh
    Dunbartonshire
    Diretor
    Kingswood 26 Waverley Avenue
    G84 7JU Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishNon Executive Director572950001

    Quem são as pessoas com controle significativo de IAN SKELLY GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06/04/2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro192238
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    IAN SKELLY GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge over bulk deposit and other receivables by way of equitable assignment and assignment
    Criado em 08/09/1994
    Entregue em 09/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    First fixed charge 1. all bulk deposits and other sums of money deposited or paid by the borrower with or to ford credit or held by ford credit on the borrower's behalf pursuant to a main dealer sale or return agreement dated 1ST april 1994 (the S.O.R. agreement) and/or the terms and conditions applicable to any stocking plan and: 2. all other monetary debts and claims due, owing or incurred to the borrower by ford motor company limited or ford credit under a main dealer agreement dated 1ST april 1994 or the S.O.R. agreement and the benefit of all rights and remedies relating thereto.
    Pessoas com direito
    • Ford Credit Europe PLC
    Transações
    • 09/09/1994Registro de uma garantia (410)
    • 17/03/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 30/08/1994
    Entregue em 08/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All new ford motor vehicles with all proceeds of sale or other disposition of any of the motor vehicles.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • Ford Credit Europe PLC
    Transações
    • 08/09/1994Registro de uma garantia (410)
    • 10/05/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Assignation
    Criado em 09/08/1994
    Entregue em 17/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All monies owing in respect of refunds of monies by way of deposit on the aquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Pessoas com direito
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transações
    • 17/08/1994Registro de uma garantia (410)
    • 05/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Assignation
    Criado em 13/12/1991
    Entregue em 16/12/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Monies due to the co from vag (united kingdom) LTD & man-vw truck & bus LTD.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 16/12/1991Registro de uma garantia
    • 21/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Letter of offset
    Criado em 05/06/1987
    Entregue em 16/06/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descrição
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/06/1987Registro de uma garantia
    Letter of offset
    Criado em 07/08/1985
    Entregue em 13/08/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company & others
    Breve descrição
    All sums due to the company by the bank on the several accounts.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/08/1985Registro de uma garantia
    Bond & floating charge
    Criado em 14/02/1983
    Entregue em 16/02/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    The whole assets of the company.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/02/1983Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0