CAPE CLADDINGS LIMITED

CAPE CLADDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAPE CLADDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC063029
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAPE CLADDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica CAPE CLADDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    KPMG RESTRUCTURING
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAPE CLADDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    J & R AITKEN (JOINERS) LIMITED06/09/197706/09/1977

    Quais são as últimas contas de CAPE CLADDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para CAPE CLADDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Término da nomeação de Rachel Nancye Amey como diretor em 08/03/2013

    1 páginasTM01

    Ata da reunião final da liquidação voluntária

    3 páginas4.26(Scot)

    Endereço do domicílio registado alterado de 2 Blythswood Square Glasgow G2 4AD em 09/10/2012

    2 páginasAD01

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:Form 600 Notice of Appointment of Liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 14/09/2012

    LRESSP

    Nomeação de Christopher Francis Judd como secretário em 23/05/2012

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Jeremy Philip Gorman como secretário em 23/05/2012

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/10/2011

    Estado do capital em 11/10/2011

    • Capital: GBP 900
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Lucy Turner como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Jeremy Philip Gorman como secretário

    1 páginasAP03

    Detalhes do diretor alterados para Rachel Nancye Carr em 01/12/2010

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 30/09/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    1 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Detalhes do secretário alterados para Lucy Finch Turner em 23/12/2009

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Victoria Anne George em 18/12/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Rachel Nancye Carr em 18/12/2009

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 30/09/2009 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    legacy

    1 páginas288c

    Contas preparadas até 31/12/2007

    1 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    Quem são os diretores de CAPE CLADDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    Secretário
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    169521610001
    GEORGE, Victoria Anne
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Diretor
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Tax Adviser134024500001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Secretário
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    GORMAN, Jeremy Philip
    2 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4AD
    Secretário
    2 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4AD
    160675450001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretário
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Secretário
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Secretário
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretário
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Secretário
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    BritishSolicitor99402260002
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Diretor
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133976650005
    ASHCROFT, Anthony
    The Long House
    Great Addington
    NN14 4BA Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    The Long House
    Great Addington
    NN14 4BA Kettering
    Northamptonshire
    BritishCompany Director31111580001
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Diretor
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    BritishAccountant131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Diretor
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    BritishChartered Accountant40873830002
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    FARRELL, John Patrick
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    Diretor
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    United KingdomBritishCompany Director702300001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Diretor
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant89560440001
    HOPWOOD, Geoffrey Alan
    22 Blackpot Lane
    Oundle
    Peterborough
    Diretor
    22 Blackpot Lane
    Oundle
    Peterborough
    BritishCompany Director829710001
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Diretor
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector15469790001
    MCKAIN, Thomas Morrison
    Horseshoe Ridge
    St George's Hill
    Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Horseshoe Ridge
    St George's Hill
    Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Director829670001
    MOSCROP, Anthony
    17 Brook Court
    Horton
    NN7 2BL Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    17 Brook Court
    Horton
    NN7 2BL Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director829680001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director829660002
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Diretor
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    SPARKES, John Leslie
    High House Bell Hill
    Lamarsh
    CO8 5EP Bures
    Suffolk
    Diretor
    High House Bell Hill
    Lamarsh
    CO8 5EP Bures
    Suffolk
    United KingdomBritish1291070001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Diretor
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritishSolicitor99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    CAPE CLADDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 20/07/2001
    Entregue em 03/08/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Legal mortgage over all real property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/08/2001Registro de uma garantia (410)
    • 04/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 18/07/2001
    Entregue em 03/08/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/08/2001Registro de uma garantia (410)
    • 04/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 27/11/1985
    Entregue em 17/12/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transações
    • 17/12/1985Registro de uma garantia
    • 09/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Floating charge
    Criado em 15/10/1985
    Entregue em 21/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due by the company and others
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 21/10/1985Registro de uma garantia
    • 09/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All securities or other property of the company held by any of the banks whether for safe custody or otherwise.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All rights, moneys or property accruing, all stocks, shares and other securities belonging to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Any financial obligation to or any sum held, received or receivable on behalf of the company by any of the banks.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All book debts and other debts due or owing to the company at the date of debenture.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Present and future goodwill of the company and the benefit of any licences, trade marks, copyrights, designs and other intellectual property.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Mortgage debenture
    Criado em 29/01/1985
    Entregue em 14/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    All estates or interests in any freehold and leasehold property together with all fixtures and fittings.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/02/1985Registro de uma garantia
    • 09/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    CAPE CLADDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    11/06/2013Data de dissolução
    14/09/2012Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    John David Thomas Milsom
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Profissional
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Jeremy Simon Spratt
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Profissional
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Notasscottish-insolvency-info

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0