RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)
Visão geral
| Nome da empresa | RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC077737 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
- Outras atividades de serviços n.e.c. (96090) / Outras atividades de serviços
Onde fica RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Endereço do escritório registrado | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despacho judicial Scheme of arrangement | 8 páginas | OC | ||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Despacho judicial Diss by c/order | 8 páginas | OC | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 27/06/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Christopher Allan Walker como diretor em 18/08/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Giselle Evette Varn como diretor em 04/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Colin David Beddall como diretor em 31/07/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Gary Park como diretor em 31/07/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Schlumberger Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 15/07/2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mikki Victoria Corcoran como diretor em 04/02/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Roman Higgins como diretor em 30/07/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Roman Higgins como secretário em 30/07/2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Mikki Victoria Corcoran em 15/03/2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Giselle Evette Varn em 15/03/2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL para 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ em 15/03/2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mrs Giselle Evette Varn como diretor em 18/01/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2020 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Simon Smoker como secretário em 29/05/2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mark Roman Higgins como secretário em 29/05/2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nomeação de Gary Park como diretor em 29/05/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDDALL, Colin David, Mr. | Diretor | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 287316070001 | |||||
| WALKER, Christopher Allan | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 299227560001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Secretário | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Secretário | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 168150570002 | |||||||
| HENDRY, Eric George | Secretário | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | British | 139588340001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Secretário | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270743080001 | |||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Secretário | 125 Hamilton Place AB2 4BD Aberdeen | British | 3742210004 | ||||||
| SMOKER, Simon | Secretário | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203976100001 | |||||||
| BARR, Lawrence Robert | Diretor | Findon AB12 4RL Aberdeen Blackhill Steading East Aberdeenshire Great Britain | United Kingdom | British | 96384280001 | |||||
| BERG, Jorgen | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | United Kingdom | Danish | 177176120001 | |||||
| BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie | Diretor | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | 216352570001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Diretor | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| BRUCE, Ronald James | Diretor | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 67939110001 | |||||
| CHANDLER, Richard | Diretor | 7310 Foster Island Drive Richmond Texas 77469 Usa | Usa | American | 113233060001 | |||||
| CORCORAN, Mikki Victoria | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 261075650001 | |||||
| DUDMAN, Bryan Leigh | Diretor | Cr 444 Waelder 78959 Texas 5974 Us | Usa | American | 137079030001 | |||||
| HENDRY, Eric George | Diretor | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139588340001 | |||||
| HIGGINS, Mark Roman | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | 256940520001 | |||||
| HOEING-COSENTINO, Karin Annette | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | German | 183326450001 | |||||
| JOHNSTON, Gregory | Diretor | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | Irish | 172272950001 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| LAU, Werner | Diretor | Grange Lodge South Avenue Cults AB1 9LP Aberdeen Aberdeenshire | West German | 3742290001 | ||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Diretor | 15 West Cults Road Cults AB15 9HQ Aberdeen | Scotland | British | 3742210006 | |||||
| MARSH, David | Diretor | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| MCGACHIE, John | Diretor | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 187731560001 | |||||
| MCROBERTS, James Greer | Diretor | Alford House One Alford Place AB1 1YB Aberdeen | British | 53510790001 | ||||||
| NICHOLSON, Peter Duncan | Diretor | The Lilies 20 Bath Street AB39 2DH Stonehaven | Scotland | British | 48078570002 | |||||
| PAISLEY, Martin William | Diretor | Cairndow PH33 6SD Onich West Highlands | British | 113228990001 | ||||||
| PARK, Gary | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 270424580001 | |||||
| SMOKER, Simon | Diretor | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| STEINKAMP, Manfred Theodor | Diretor | Westwinds Cammachmore Stonehaven Aberdeen | West German | 3742280001 | ||||||
| SUTTON, Neal | Diretor | County Road 242 Shiro 77876 Texas P O Box 10 Usa | American | 50209290001 | ||||||
| VARN, Giselle Evette | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 273564740002 | |||||
| WERNER, Richard | Diretor | 3507 Newcastle Drive 77027 Houston Texas Usa | American | 50209320002 | ||||||
| WILDE, Geraldine | Diretor | 2819 Hazy Hillside Ct 77345 Kingwood Tx Usa | Usa | American | 56051310001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlumberger Uk Limited | 06/04/2016 | Manor Royal RH10 9BU Crawley Minerva United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Criado em 23/11/1988 Entregue em 01/12/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Lease of ground on the southside of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 14/11/1988 Entregue em 21/11/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Standard security | Criado em 19/01/1984 Entregue em 31/01/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição 0.9 acres situated on or towards the south side of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 09/09/1983 Entregue em 20/09/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0