BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED

BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC089468
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    • construção de edifícios comerciais (41201) / Construção

    Onde fica BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LENDLEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED01/07/201601/07/2016
    LEND LEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED28/02/201128/02/2011
    BOVIS LEND LEASE (SCOTLAND) LIMITED01/02/200001/02/2000
    BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED29/11/198429/11/1984
    QUITTE LIMITED29/08/198429/08/1984

    Quais são as últimas contas de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2025
    Próximas contas vencem em31/03/2026
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2024

    Qual é o status da última declaração de confirmação para BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até29/04/2026
    Próxima declaração de confirmação vence13/05/2026
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até29/04/2025
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2025 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Lendlease Construction Holdings (Europe) Limited como pessoa com controlo significativo em 31/03/2025

    2 páginasPSC05

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Contas anuais preparadas até 30/06/2024

    30 páginasAA

    Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/06/2025 para 31/03/2025

    1 páginasAA01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 28/03/2025

    • Capital: GBP 98,500,100
    3 páginasSH01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed lendlease construction (scotland) LIMITED\certificate issued on 01/04/25
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name01/04/2025

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Término da nomeação de Simon William Gorski como diretor em 23/08/2024

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2023

    28 páginasAA

    Nomeação de David Edward Cadiot como diretor em 16/01/2024

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2022

    29 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Tom Gillibrand como diretor em 05/01/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Louise Nicola Bramble como diretor em 04/01/2023

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2021

    25 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Louise Nicola Bramble como diretor em 14/12/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Michelle Gaye Letton como diretor em 14/12/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2020

    22 páginasAA

    Término da nomeação de Peter Dominic Leonard como diretor em 18/02/2021

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de Lendlease, 77 Renfield Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH Scotland para 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH em 07/09/2020

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 29/04/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon William Gorski em 10/02/2017

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CADIOT, David Edward
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish281962250001
    GILLIBRAND, Tom
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish303891700001
    CATCHPOLE, Laurence James
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    Secretário
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    British580980001
    CHADWICK, Peter Roy
    24 Pendarves Road
    Raynes Park
    SW20 8TS London
    Secretário
    24 Pendarves Road
    Raynes Park
    SW20 8TS London
    British37525040002
    CUTTS, Alistair
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Secretário
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    British103721920002
    MARTIN, Neil Christopher
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretário
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British92464400001
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    United Kingdom
    Secretário
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro05306796
    102944500001
    ALLPORT, Roy Innes
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    ScotlandBritish185943820001
    ANDERSON, Gordon Adam
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish62089480001
    ASH, Gordon Brian
    The Coach House
    Auchengillan
    G63 9AU Blanefield
    Stirlingshire
    Diretor
    The Coach House
    Auchengillan
    G63 9AU Blanefield
    Stirlingshire
    British82612740001
    BALLANTYNE, John Charles
    30 Rosemount
    Cumbernauld
    G68 0HL Glasgow
    Diretor
    30 Rosemount
    Cumbernauld
    G68 0HL Glasgow
    British53470410001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Diretor
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BRAMBLE, Louise Nicola
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish256411060001
    CATCHPOLE, Laurence James
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    Diretor
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    British580980001
    COLEMAN, Murray Leslie
    Laurel House
    Queens Road
    TW10 6JJ Richmond
    Surrey
    Diretor
    Laurel House
    Queens Road
    TW10 6JJ Richmond
    Surrey
    Australian114401640001
    COOK, George Lamond
    75 Cash Feus
    Strathmiglo
    KY14 7QP Cupar
    Fife
    Diretor
    75 Cash Feus
    Strathmiglo
    KY14 7QP Cupar
    Fife
    ScotlandScottish51373080001
    DEW, Beverley Edward John
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish133103950001
    DOWNIE, Henry Francis
    42 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    42 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    British1357800001
    DYKE, Michael Sean
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish187622030001
    GANDY, Paul Francis
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish71452580002
    GLEDHILL, Lisa Veronica
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish178456550002
    GORSKI, Simon William
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish215280250003
    GRIST, Stephen Kenneth
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandAustralian157560950001
    HARVEY, Colin Stephen
    8 Montrose Close
    SK10 3QY Macclesfield
    Cheshire
    Diretor
    8 Montrose Close
    SK10 3QY Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish96158420001
    HEYES, Michael
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish189835920001
    HYNE, John Charles
    6 Broomhill Park
    EH22 3JX Eskbank
    Midlothian
    Diretor
    6 Broomhill Park
    EH22 3JX Eskbank
    Midlothian
    British100669250001
    JOHNSON, Paul Murray
    Ranelagh House
    2 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Diretor
    Ranelagh House
    2 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    EnglandBritish115607320001
    LABBAD, Daniel
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandAustralian111679880003
    LEONARD, Peter Dominic
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    United KingdomBritish280048870001
    LETTON, Michelle Gaye
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Diretor
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandAustralian267826300001
    MABEY, Roger Stanley
    Carrol Lodge
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham Village
    Berkshire
    Diretor
    Carrol Lodge
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham Village
    Berkshire
    EnglandBritish156243050001
    MACK, Alan Charles
    Manesty
    18 Apperley Road
    NE43 7PG Stocksfield
    Northumberland
    Diretor
    Manesty
    18 Apperley Road
    NE43 7PG Stocksfield
    Northumberland
    British81122300001
    MARTIN, Neil Christopher
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Diretor
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish317424620001
    MCMURDO, John Stuart
    Westlea 58 Majors Loan
    FK1 5QG Falkirk
    Stirlingshire
    Diretor
    Westlea 58 Majors Loan
    FK1 5QG Falkirk
    Stirlingshire
    British78860160001
    MCQUADE, Brian
    289 Main Road
    Elderslie
    PA5 9ED Johnstone
    Diretor
    289 Main Road
    Elderslie
    PA5 9ED Johnstone
    British75590650001

    Quem são as pessoas com controle significativo de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Crown Place
    EC2A 4ES London
    30
    England
    06/04/2016
    Crown Place
    EC2A 4ES London
    30
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00231889
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0